DEPOTS DES COMPTES
25/10/2008 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

rue Denis Papin Z I 59147 Gondecourt
17/09/2009 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

rue Denis Papin Z I 59147 Gondecourt
27/06/2011 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

rue Denis Papin Z I 59147 Gondecourt
03/01/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

rue Denis Papin z 59147 Gondecourt
20/08/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

rue Denis Papin z 59147 Gondecourt
10/09/2014 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

rue Denis Papin z 59147 Gondecourt
19/12/2017 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

rue Denis Papin z 59147 Gondecourt
02/10/2022 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

rue Denis Papin z I 59147 Gondecourt
MODIFICATION
13/03/2011 Départ de commissaire aux comptes

Gérant : HAQUETTE Michel

rue Denis Papin Z I 59147 Gondecourt
25/12/2012 modification survenue sur l'administration

nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AX-AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT FM

rue Denis Papin z 59147 Gondecourt
05/06/2013 modification survenue sur le capital (augmentation)

Capital : 507 000,00 EUR

rue Denis Papin z 59147 Gondecourt
03/04/2014 modification survenue sur l'administration

nomination du Gérant : Haquette, nom d'usage : M'fah Traore, Lucie

rue Denis Papin z 59147 Gondecourt
25/02/2015 modification survenue sur la forme juridique et l'administration

nomination du Président : AYAHO MANAGEMENT, modification du Gérant Haquette, Michel, Gérant partant : Haquette, nom d'usage : M'fah Traore, Lucie

rue Denis Papin z 59147 Gondecourt
04/03/2015 modification survenue sur l'administration

Président partant : AYAHO MANAGEMENT, nomination du Président : A&G INDUSTRIES

rue Denis Papin z 59147 Gondecourt
VENTE ET CESSION
31/05/2014 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

Cessions de la société au samedi 31 mai 2014

Catégorie : Autre achat, apport, attribution

Description : PROJET DE FUSION ENTREMICHEL HAQUETTE EXP. Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros Siège social : Z.I. rue Denis Papin BP 15 59147 GONDECOURT 519 132 856 RCS LILLE METROPOLEETINDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O. Société à

Opposition : Article L.236-14 du code de commerce

31/05/2014 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

Cessions de la société au samedi 31 mai 2014

Catégorie : Autre achat, apport, attribution

Description : PROJET DE FUSION ENTREMICHEL HAQUETTE EXP. Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros Siège social : Z.I. rue Denis Papin BP 15 59147 GONDECOURT 519 132 856 RCS LILLE METROPOLEETINDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS I.S.E.R.C.O. Société à

Opposition : Article L.236-14 du code de commerce

Voir la fiche Sirene de INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS Voir le rapport économique de INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS
PILONNE RENOVATION ASCENSEUR SERRURERIE
THAO LEA
SIGNATURE ORTHOPAEDICS FRANCE
ROUGE VIF 13
MC CONSEIL
CAISSE DES ECOLES DE NEUVILLY