DEPOTS DES COMPTES
21/11/2008 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
24/09/2009 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
23/09/2010 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
31/10/2011 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
03/09/2012 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
05/09/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
16/08/2014 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
02/09/2015 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
02/09/2016 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
03/11/2017 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
04/09/2018 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
04/02/2020 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
12/07/2022 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
26/07/2022 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
MODIFICATION
08/01/2008 Modification de représentant.

Co-gérant : ROULOT Frederic Pierre Rene radiation le 07 Décembre 2007. Co-gérant : QUANDALLE Vincent André Michel Marie en fonction le 07 Décembre 2007.

26/02/2009 Modification de représentant.

Gérant : PETIT JEAN-PIERRE. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST &
YOUNG AUDIT modification le 17 Août 2006. Co-gérant : CHAMPETIER DE RIBES Gregoire Desire en fonction le 17 Août 2006. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 17 Août 2006. Co-gérant : QUANDALLE Vincent André Michel Marie en fonction le 07 Décembre 2007. Co-gérant : PERRI Salvatore en fonction le 14 Février 2009.

28/07/2009 Modification de représentant.

Gérant : PETIT JEAN-PIERRE. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 17 Août 2006. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 17 Août 2006. Co-gérant : QUANDALLE Vincent André Michel Marie en fonction le 07 Décembre 2007. Co-gérant : PERRI Salvatore en fonction le 14 Février 2009. Co-gérant non associé : TRABELSI Nawfal en fonction le 20 Juillet 2009.

06/02/2011 Modification de représentant.

Gérant : PETIT JEAN-PIERRE Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 17 Août 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 17 Août 2006 Co-gérant : QUANDALLE Vincent André Michel Marie en fonction le 07 Décembre 2007 Co-gérant : TRABELSI Nawfal modification le 30 Juillet 2009

06/02/2011 Modification de représentant.

Gérant : PETIT JEAN-PIERRE Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 17 Août 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 17 Août 2006 Co-gérant : QUANDALLE Vincent André Michel Marie en fonction le 07 Décembre 2007 Co-gérant : TRABELSI Nawfal modification le 30 Juillet 2009 Co-gérant : DE NORONHA LOPES Joao en fonction le 28 Janvier 2011 Co-gérant : BOURDON Alexis en fonction le 28 Janvier 2011

10/08/2012 Modification de représentant.

Gérant : PETIT JEAN-PIERRE Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 01 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 01 Août 2012 Co-gérant : QUANDALLE Vincent André Michel Marie en fonction le 07 Décembre 2007 Co-gérant : TRABELSI Nawfal modification le 30 Juillet 2009 Co-gérant : DE NORONHA LOPES Joao en fonction le 28 Janvier 2011 Co-gérant : BOURDON Alexis en fonction le 28 Janvier 2011 Co-gérant : MONGON Hubert en fonction le 01 Août 2012

18/04/2013 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 01 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 01 Août 2012 Gérant : QUANDALLE Vincent André Michel Marie en fonction le 07 Décembre 2007 Gérant : TRABELSI Nawfal modification le 30 Juillet 2009 Gérant : BOURDON Alexis en fonction le 28 Janvier 2011 Gérant : MONGON Hubert en fonction le 01 Août 2012 Gérant non associé : DUBOIS Isabelle en fonction le 10 Avril 2013

08/08/2014 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 01 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 01 Août 2012 Gérant : TRABELSI Nawfal modification le 30 Juillet 2009 Gérant : BOURDON Alexis en fonction le 28 Janvier 2011 Gérant : MONGON Hubert en fonction le 01 Août 2012 Gérant non associé : DUBOIS Isabelle en fonction le 10 Avril 2013 Gérant : CHAPUIS Christophe Eric en fonction le 31 Juillet 2014

28/01/2016 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 01 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 01 Août 2012 Gérant : TRABELSI Nawfal modification le 30 Juillet 2009 Gérant : BOURDON Alexis en fonction le 28 Janvier 2011 Gérant : MONGON Hubert en fonction le 01 Août 2012 Gérant non associé : DUBOIS Isabelle en fonction le 10 Avril 2013 Gérant : CHAPUIS Christophe Eric en fonction le 31 Juillet 2014 Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne en fonction le 21 Janvier 2016

31/03/2016 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 01 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 01 Août 2012 Gérant : TRABELSI Nawfal modification le 25 Février 2016 Gérant : BOURDON Alexis en fonction le 28 Janvier 2011 Gérant non associé : DUBOIS Isabelle en fonction le 10 Avril 2013 Gérant : CHAPUIS Christophe Eric en fonction le 31 Juillet 2014 Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne en fonction le 21 Janvier 2016 Gérant : SILVA Claire Martine en fonction le 24 Mars 2016

30/04/2018 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 01 Août 2012 ;
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 01 Août 2012 ;
Gérant : TRABELSI Nawfal modification le 25 Février 2016 ;
Gérant : BOURDON Alexis en fonction le 28 Janvier 2011 ;
Gérant non associé : DUBOIS Isabelle en fonction le 10 Avril 2013 ;
Gérant : CHAPUIS Christophe Eric en fonction le 31 Juillet 2014 ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne en fonction le 21 Janvier 2016

30/04/2018 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 01 Août 2012 ;
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 01 Août 2012 ;
Gérant : BOURDON Alexis en fonction le 28 Janvier 2011 ;
Gérant : CHAPUIS Christophe Eric en fonction le 31 Juillet 2014 ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne en fonction le 21 Janvier 2016 ;
Gérant : DEWAELE Delphine Thérèse en fonction le 26 Avril 2018 ;
Gérant : BISSON Eric Robert en fonction le 26 Avril 2018

05/06/2019 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 01 Août 2012 ;
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 01 Août 2012 ;
Gérant : BOURDON Alexis en fonction le 28 Janvier 2011 ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne en fonction le 21 Janvier 2016 ;
Gérant : DEWAELE, SMAGGHE Delphine Thérèse modification le 12 Avril 2019 ;
Gérant : BISSON Eric Robert modification le 12 Avril 2019 ;
Gérant : LEDUC, FONNESU Hélène Odette Marie Clémence en fonction le 03 Juin 2019 ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis en fonction le 03 Juin 2019 ;
Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette en fonction le 03 Juin 2019 ;
Gérant : BORDAS Sébastien en fonction le 03 Juin 2019

30/09/2019 Modification de l'activité.



05/06/2020 Modification survenue sur l'administration.

Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette ;
Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : FONNESU Hélène Odette Marie Clémence ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BOURDON Alexis ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
17/11/2020 Modification survenue sur l'administration.

Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette ;
Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : FONNESU Hélène Odette Marie Clémence ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BOURDON Alexis ;
Gérant : BESSET Jean-Yves ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
17/11/2020 Modification survenue sur l'administration.

Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette ;
Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BOURDON Alexis ;
Gérant : HASSAM Salime ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
10/12/2020 Modification survenue sur l'administration.

Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette ;
Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BOURDON Alexis ;
Gérant : BARON Hervé ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
16/01/2022 Modification survenue sur l'administration.

Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette ;
Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
20/10/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette ;
Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
20/10/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette ;
Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
20/10/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette ;
Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
20/10/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette ;
Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Gérant : RIMLINGER Mathieu ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
20/10/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : JACOPIN Fabienne Irène Marie Antoinette ;
Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Gérant : RIMLINGER Mathieu ;
Gérant : SEKSIK Sandrine ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
20/10/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : BISSON Eric Robert ;
Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Gérant : RIMLINGER Mathieu ;
Gérant : SEKSIK Sandrine ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
20/10/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : LE BERRE Michel Jean Louis ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Gérant : RIMLINGER Mathieu ;
Gérant : SEKSIK Sandrine ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
20/10/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : BORDAS Sébastien ;
Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Gérant : RIMLINGER Mathieu ;
Gérant : SEKSIK Sandrine ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
22/10/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : SMAGGHE Delphine Thérèse ;
Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Gérant : RIMLINGER Mathieu ;
Gérant : SEKSIK Sandrine ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
22/10/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Gérant : RIMLINGER Mathieu ;
Gérant : SEKSIK Sandrine ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
31/12/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : ROYAUX Xavier Marie Olivier Anne ;
Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Gérant : RIMLINGER Mathieu ;
Gérant : SEKSIK Sandrine ;
Gérant : BERTOLA jean-Guillaume ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
18/01/2024 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : BARON Hervé ;
Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Gérant : RIMLINGER Mathieu ;
Gérant : SEKSIK Sandrine ;
Gérant : BERTOLA jean-Guillaume ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
21/01/2024 Modification survenue sur l\'administration.

Gérant : GIRARD Romain, Marc, Joanny, André ;
Gérant : STRACHWITZ Aglaë ;
Gérant : DUCLOS Amélie ;
Gérant : ROCCA Rémi ;
Gérant : RIMLINGER Mathieu ;
Gérant : SEKSIK Sandrine ;
Gérant : BERTOLA jean-Guillaume ;
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT

1 Rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt
Voir la fiche Sirene de MC DONALD'S FRANCE SERVICE Voir le rapport économique de MC DONALD'S FRANCE SERVICE
RUBIS
ASS VAR OUEST INITIATIVE DEVELOPPEMENT
K SYSTEM MANAGEMENT
SCI BANDARE
ASTRO-TERRE
CUMA DES LIGNERES