Date Société Description Liens
28/08/2009

EARL DU PETIT BOIS

381424142 - E.A.R.L.
Capital : 15 244,90 EUR

Changement de gérant

Gérant : MOREAU Aline Juliette

lieu-dit la Noé 35130 Moutiers
28/08/2009

SODIFRANCE

383139102 - Société anonyme à directoire
Capital : 5 000 000,00 EUR

Changement de commissaire aux comptes Changement de membres du conseil de surveillance

Président du directoire : MAZIN Franck Max Francis Président du conseil de surveillance : DERAM Eric Jean Claude Vice-président du conseil de surveillance : ANGOT Bernard Michel Membre du directoire : MAZIN Anne-Laure Catherine Eliane Membre du directoire : LENNON Yves Pierre Membre du directoire : RIVIERE DE PRECOURT Frederic Membre du conseil de surveillance : UNI EXPANSION OUEST Membre du conseil de surveillance : JOUSSET Gérard Membre du conseil de surveillance : CLAVERIE Gérard Membre du conseil de surveillance : SYNERGIE FINANCE GESTION Membre du conseil de surveillance : SODERO GESTION Directeur général : LENNON Yves Pierre Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR GRANT THORNTON Commissaire aux comptes titulaire : SOLIS - MARC DHERBEY & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoît Commissaire aux comptes suppléant : ARPEGE AUDITEURS ASSOCIES

avenue Saint Vincent Parc d'Activité la Bretèche 35760 Saint-Grégoire
28/08/2009

SCEA DE LA VALLIERE, SOCIETE EN LIQUIDATION

393070750 - S.C.E.A.
Capital : 30 489,80 EUR

Dissolution

Liquidateur amiable : CHAUVEL Jean-Marie Ange Marc

la Basse Foucherie 35500 Vitré
28/08/2009

EARL LA HERSONNAIS

417642295 - E.A.R.L.

Transformation de G.A.E.C. en E.A.R.L. Changement de gérant

Gérant : SAUVEE Olivier Michel

la Hersonnais 35630 Vignoc
28/08/2009

ATELIER DES SIGNES SARL

392031522 - Société à responsabilité limitée
Capital : 8 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : POUCHIN Olivier Michel Bernard

Z.A. la Gaultière 35220 Châteaubourg
28/08/2009

INTER-AVIC

381886696 - Société en nom collectif
Capital : 352 015,75 EUR

Réduction du capital Changement de composition des associés

Gérant associé en nom : FRANCE SEXAGE, représenté par M CHAUVEY Joël Pierre Marie Gérant associé en nom : JAOUEN Patrice Louis Marie Associé en nom collectif : HOUSSAY Jean-Pascal Joseph Marie Associé en nom collectif : DANIEL Isabelle Fernande Jeanne Marie Associé en nom collectif : GREGOIRE Gwenaëlle Marie-Annick Gilberte Associé en nom collectif : THOMAS Christine Suzanne Marie Associé en nom collectif : BRETEL Loïc Louis Associé en nom collectif : ROUX Christele Marie Lucienne Associé en nom collectif : GAILLARD Marie-Lea Jeanne Simone Associé en nom collectif : BALAVOINE Claude Jean Baptiste Associé en nom collectif : BARBIER Valérie Jeanne Patricia Associé en nom collectif : LEPINAY Stéphane René Jacques Associé en nom collectif : BOUGUET Fabienne Josette Danielle Associé en nom collectif : CARREE Guylaine Lucienne Yvonne Associé en nom collectif : GAINCHE Christine Anne-Marie Associé en nom collectif : BLAYO Anne-Marie Catherine Dominique Associé en nom collectif : GAUDIN Nadine Aline Rolande Associé en nom collectif : ETRILLARD Géraldine Simone Annick Rose Associé en nom collectif : GAILLARD Nathalie Associé en nom collectif : CAP'ARVEN Associé en nom collectif : EVEILLARD Jean-Luc Associé en nom collectif : BOUESSEL Mickael Associé en nom collectif : FRIN Véronique Associé en nom collectif : BENOIT Benjamin Associé en nom collectif : BERNARD Eric Michel Yves Associé en nom collectif : CALMET Herri Yvonnick Marie Associé en nom collectif : LE SAUX Philippe Associé en nom collectif : BELLIL Lydie Associé en nom collectif : MERCIER Jean Associé en nom collectif : JEGOUIC Jacques Associé en nom collectif : CHEVALLIER Cédric Associé en nom collectif : GEFFROY Marie-Paule Associé en nom collectif : LEBRETON Annie Associé en nom collectif : JUMELAIS Mathieu Associé en nom collectif : RIGAUD Marylène Associé en nom collectif : CORDEROCH Gaëtan Associé en nom collectif : DENOT Alain Associé en nom collectif : LE GOFF Thierry Associé en nom collectif : GAUTIER Véronique Associé en nom collectif : RONDOUIN Philippe Associé en nom collectif : BOCHE Gwendolyne Associé en nom collectif : MAUDUIT Pascale Associé en nom collectif : MICHEL Bernard Associé en nom collectif : COYEN Marie-Therese Associé en nom collectif : HAMON Elodie Associé en nom collectif : GUERY Andre Associé en nom collectif : TOSTIVINT Celine Associé en nom collectif : DANION Arnaud Associé en nom collectif : COUILLAUD Sindy Associé en nom collectif : ZIYAVOV Ziyavoutdine Associé en nom collectif : AFTIS Aresky Associé en nom collectif : LE BELLEGO Gildas Associé en nom collectif : WISNIESKI Kordian Associé en nom collectif : KRAJEWSKI Mateusz Associé en nom collectif : DUHOUX Maud Associé en nom collectif : GARLANTEZEC Romain Commissaire aux comptes titulaire : AMB CONSULTANTS Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHEE Philippe

1 rue des Métiers Z.A. du Chesnot 35160 Breteil
28/08/2009

EPIGASTRE

487771107 - Société d'exercice libéral A.R.L.
Capital : 30 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : DUDICOURT Jean-Christophe Léon Edmond Gérant : MARION Jean Gérant : PLIHON Geneviève Christine Marie Andrée Gérant : GORLOT Ingrid

8 rue du Chène Germain 35510 Cesson-Sévigné
28/08/2009

O2 KID RENNES

511267742 - S.A.R.L. à associé unique
Capital : 1 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant non associé : RICHARD Guillaume

61 rue de Lorient 35000 Rennes
28/08/2009

PROCOM

481733954 - Société en nom personnel

Transfert d'établissement principal avec création

Personne infiniment responsable : DUBOIS Yannick, Gilbert, Roland

48 rue Paul Cocteau 37320 Esvres
28/08/2009

SARL HOTEL DU CYGNE

326168960 - S.A.R.L. à associé unique
Capital : 7 622,45 EUR

Changement de gérant Changement de forme

Gérant : HUANG Victor

6 rue du Cygne 37000 Tours
28/08/2009

DARINE

398457457 - Société à responsabilité limitée
Capital : 7 622,45 EUR

Changement de gérant

Co-gérant : MOREAU Mehdi Denis Sylvain Co-gérant : DEASY Jeanne Alecia

1 rue Etienne Cosson 37170 Chambray-lès-Tours
28/08/2009

CONCEPT INTERIEUR

403085194 - Société à responsabilité limitée
Capital : 7 622,45 EUR

Changement de gérant

Gérant : DEASY Jeanne Alecia

74 avenue du Grand Sud 37170 Chambray-lès-Tours
28/08/2009

TOURS DE CHANT

404565830 - Société à responsabilité limitée
Capital : 7 622,45 EUR

Changement de gérant

Gérant : BOISSON DE CHAZOURNES Félix Bruno

45-47 rue Marceau 37000 Tours
28/08/2009

FIDUSOFT

411372923 - Société anonyme à conseil d'administration
Capital : 768 000,00 EUR

Départ d'un administrateur Changement de président du conseil d'administration et du directeur général

Président du conseil d'administration et directeur général : PONTROUE Benoît Marie Jean Administrateur : VILLAIN Claude Marcel Paul Administrateur : BACHELIER-LUBIN Jacques Marie Henri Commissaire aux comptes titulaire : COULON Alain Commissaire aux comptes suppléant : ALAIN COULON AUDIT CONSEIL

3 bis rue de la Tuilerie 37550 Saint-Avertin
28/08/2009

BERNY M & S

420715708 - Société à responsabilité limitée
Capital : 38 112,25 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Co-gérant : GAUGRY Stéphane Roland Roger Co-gérant : BERNY Max Yves Commissaire aux comptes titulaire : CROZON Jean-François Commissaire aux comptes suppléant : CLAUDEL Pierre

la Borde 37110 Monthodon
28/08/2009

TRANS LOIRE EXPRESS

421994583 - Société à responsabilité limitée
Capital : 11 128,78 EUR

Changement de gérant

Gérant : MOREAU Edith Raymonde

7 avenue de la Loire Z I les Poujeaux 37530 Nazelles-Négron
28/08/2009

INTERPOOL RESEAU

431235258 - Société par actions simplifiée
Capital : 62 000,00 EUR

Changement de président de S.A.S.

Président de la société : RAVIER Thierry Maurice Administrateur : SAINT-JEAN Didier René Fernand Administrateur : ISELIN Vincent Administrateur : SELLIER Claude Eugène Administrateur : BENITO Bernard Francis Administrateur : BIGONNEAU Alain Patrick Pierre Commissaire aux comptes titulaire : JEHANNO Dominique Commissaire aux comptes suppléant : CARMENT Antoine

rue Gaspard Monge Z.A.C. de Conneuil 37270 Montlouis-sur-Loire
28/08/2009

VOLTERAM

315905141 - Société à responsabilité limitée
Capital : 150 000,00 EUR

Augmentation de capital

Gérant : LERICHE Laurent Luc Josselin

Z I la Coudrière 37210 Parçay-Meslay
28/08/2009

HBED

441568581 - Société à responsabilité limitée
Capital : 9 000,00 EUR

Départ de co-gérant Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : DEASY Jeanne Alecia

Mon Idée 37800 Saint-Epain
28/08/2009

BLEU MARINE LOC

445353089 - Société à responsabilité limitée
Capital : 8 000,00 EUR

Changement d'activité Changement de forme

Gérant : LE POUPON Denis Jacques Franco

le Poirier la Belle 37210 Rochecorbon
28/08/2009

MV.COURTAGE

449167170 - Société à responsabilité limitée
Capital : 7 800,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : LELARGE Willy Frédéric Gérard

31 rue du Bois Bouquin 37110 Chateau Renault
28/08/2009

VERSUS STATION

482809050 - Société à responsabilité limitée
Capital : 6 000,00 EUR

Cessation d'activité avec dissolution

Liquidateur amiable : SPIES Laurent Guy

16 rue des Trois Ecritoires 37000 Tours
28/08/2009

A.M.I. RAYONNAGE

484035878 - S.A.R.L. à associé unique
Capital : 10 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement d'activité

Gérant : ODILLE Franck

15 rue de la Gratiole Z.I. les Brosses N°2 37270 Larçay
28/08/2009

CEF BOISSONS

492188487 - Société à responsabilité limitée
Capital : 30 000,00 EUR

Augmentation de capital Changement de gérant Changement d'activité

Gérant : FIGUEIREDO Philippe Michel

7 rue les Terrages 37390 Saint Roch
28/08/2009

ESPACE BLANC NATURE

493677678 - Société à responsabilité limitée
Capital : 12 000,00 EUR

Changement de gérant Nomination d'un co-gérant

Co-gérant : BAILLET Jean-Yves Michel Marie Co-gérant : ROUSSEAU Laurence Marie Danielle

28 rue Picois 37600 Loches
28/08/2009

GALAPAT'S

500366737 - Société à responsabilité limitée
Capital : 8 000,00 EUR

Cessation d'activité avec dissolution

Liquidateur amiable : VAZELLE Patrick Jean-Pierre

9 rue Jules Charpentier 37000 Tours
28/08/2009

ECO-ENERGIES TOURAINE

509140422 - Société à responsabilité limitée
Capital : 5 000,00 EUR

Changement de gérant

Co-gérant : DHORMES Nicolas Alphonse André Co-gérant : ERAUD Agnès Marcelle Co-gérant : DEASY Jeanne Alecia

74 avenue du Grand Sud 37170 Chambray-lès-Tours
28/08/2009

MOREL RECUPERATION FERRAILLE METAUX EPAVE

344962931 - Société en nom personnel

Changement d'activité

Personne infiniment responsable : MOREL Pascal

rue du Haut Mas 42150 La Ricamarie
28/08/2009

GOBAT

433906724 - Société en nom personnel

Changement de nom commercial

Personne infiniment responsable : GOKSEN Kadir

19 rue de la République 42500 Le Chambon-Feugerolles
28/08/2009

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARBAUD

340700624 - Société civile immobilière
Capital : 762,25 EUR

Cessation d'activité avec dissolution

Liquidateur amiable : LANION Martine

71-73 la Malafolie 42500 Le Chambon-Feugerolles
28/08/2009

LE TOIT FOREZIEN

574501714 - Société coopérative d'intérêt collectif anonyme
Capital : 42 134,40 EUR

Changement de directeur général Nomination du directeur général délégué.

Président du conseil d'administration : HENRY Jacky Yves Michel Directeur général : MATTIUSSI Mario Directeur général délégué : ODOUARD François Marie Jean Administrateur : PINET Daniel Administrateur : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, représenté par M ZENNAF Kahier Administrateur : UNION DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS C.G.T., représenté par MLE VALLA Martine Administrateur : UNION DEPARTEMENTAL SYNDICATS C.F.D.T., représenté par MME PEYRARD Claude Marie Jeanne Administrateur : 1% LOGEMENT LOIRE Administrateur : CREDIT COOPERATIF, représenté par M AVO José Antonio Administrateur : BONIFAT Michel Administrateur : CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT, représenté par MME SCHOPPIG Myriam Administrateur : FARLAY Jean Claude Antoine Administrateur : SAINT ETIENNE METROPOLE, représenté par M BOUTHEON Henry Michel Administrateur : MONNET Marie Claude Eugénie Louise Administrateur : UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO, représenté par MME ORIOL Bernadette Administrateur : CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES CSF, représenté par M DOPPLER François Louis Marie Administrateur : YAHYA Driss Administrateur : PACT LOIRE, représenté par M HERRGOTT Antoine Pierre Administrateur : DAHMANI Marylène Administrateur : AIT MANSOUR Alexandre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROYET Commissaire aux comptes suppléant : TRIOLLIER Daniel

29 rue jo Gouttebarge 42000 Saint-Etienne
28/08/2009

PISCINE FACILE

494843592 - Société à responsabilité limitée
Capital : 2 100,00 EUR

Changement de gérant Transformation en société à responsabilité limitée

Gérant : RIVOLLIER Jérôme Joseph Joël

le Communal 42210 Marclopt
28/08/2009

CASINO DE MONTROND LES BAINS

885550327 - Société par actions simplifiée
Capital : 459 000,00 EUR

Changement de commissaire aux comptes

Président : BRUYERE Michel Joseph Alexandre Directeur général : FOREST-DODELIN Laurent Pierre Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne

route de Roanne 42210 Montrond-les-Bains
28/08/2009

SCI I.V.V.

452289069 - Société civile
Capital : 600,00 EUR

Départ de co-gérant Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : HOUG Didier Associé : HOUG Didier Associé : PRALONG Paulette Rosalie Sylvie

16 allée des Myosotis 42340 Veauche
28/08/2009

MP STUDIO

513409151 - Société à responsabilité limitée
Capital : 1 000,00 EUR

Mise en activité suite à création

Co-gérant : ROLLE Priscilla Co-gérant : LAINSER Monia

6 rue Louis Merley 42000 Saint-Etienne
28/08/2009

CONSTRUCTIONS METALLIQUES RICHARD

311262703 - Société par actions simplifiée
Capital : 364 100,00 EUR

Augmentation de capital

Président de la société : RICHARD Louis Paul Francis Marie Commissaire aux comptes titulaire : NICOL PELE BRODU Commissaire aux comptes suppléant : BRODU Guy

25 rue du Vignoble 44330 La Chapelle-Heulin
28/08/2009

OCABURO

327796884 - Société anonyme à directoire
Capital : 203 455,00 EUR

Augmentation de capital

Président du directoire : BLANCHET DHUISMES François Christian Président du conseil de surveillance : BLANCHET DHUISMES Jean-François Vice-président du conseil de surveillance : BLANCHET-DHUISME Valérie Florence Membre du directoire : BLANCHET-DHUISMES Virginie Hélène Jeanne Membre du conseil de surveillance : URIARTE Chantale Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS Commissaire aux comptes suppléant : CHAPISEAU Alain

les Piliers de la Chauvinière 44800 Saint Herblain
28/08/2009

EARL DE LA MABONNIERE

334958394 - E.A.R.L.
Capital : 45 000,00 EUR

Réduction du capital

Gérant : PEIGNE Michel Joseph

la Mabonnière 44150 Oudon
28/08/2009

ALFA.SAFETY

405100587 - Société à responsabilité limitée
Capital : 295 092,12 EUR

Augmentation de capital

Gérant : BOISSON Jean-Paul Roger Marie

15 rue Lamoricière 44100 Nantes
28/08/2009

JEFCO DEVELOPPEMENT

438388621 - Société à responsabilité limitée
Capital : 1 150,00 EUR

Réduction du capital

Gérant : DESHAYES Jean-François Charles

18 avenue de Langeais 44800 Saint Herblain
28/08/2009

ABALONE TT 49-85

440268589 - Société à responsabilité limitée
Capital : 40 000,00 EUR

Changement de commissaire aux comptes

Gérant : MOUTEL Francois-Xavier Bernard Guy Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes suppléant : CO-PILOTES

7 ter boulevard Allard 44000 Nantes
28/08/2009

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA FAMILLE GIRAUDEAU-PATRON

441441599 - Groupement foncier agricole
Capital : 38 308,00 EUR

Réduction du capital

Associé indéfiniment responsable : PATRON Janine Co-gérant associé indéfiniment responsable : PATRON Joseph Alexandre Jean Co-gérant associé indéfiniment responsable : GIRAUDEAU Jean-Pierre Armand Joseph Léon Co-gérant associé indéfiniment responsable : GIRAUDEAU Daniel Denis Bernard Marie

le Petit Logis Pont James 44310 Saint Colomban
28/08/2009

ATN OUEST

451724652 - Société par actions simplifiée
Capital : 50 000,00 EUR

Changement de commissaire aux comptes

Président de la société : MIYX Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : VOLLE Christian Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT MAISONNEUVE

11 rue du chemin Rougé Centre Exalis - Batiment E 44300 Nantes
28/08/2009

ATN OUEST

451724652 - Société par actions simplifiée
Capital : 50 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Président de la société : MIYX Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : VOLLE Christian Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT MAISONNEUVE

11 rue du chemin Rougé Centre Exalis - Batiment E 44300 Nantes
28/08/2009

ALTEA FINANCES

414324699 - Société par actions simplifiée
Capital : 3 165 000,00 EUR

Augmentation de capital

Président de la société : MEVEL Fabien Directeur général : ROZE Benoît Jean Michel Commissaire aux comptes titulaire : EXCO BRETAGNE - A.B.O. Commissaire aux comptes suppléant : GAUDE Alain

153 route des Sorinières 44400 Rezé
28/08/2009

SCI DAOUDAL

453610065 - Société civile immobilière
Capital : 1 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Déclaration des nouveaux associés

Associé indéfiniment responsable : DAOUDAL Anne-Gaëlle Jeanne Associé indéfiniment responsable : DAOUDAL Solène Dominique Gérant associé indéfiniment responsable : DAOUDAL René Jean Pierre

17 rue Russeil 44000 Nantes
28/08/2009

SARL CAS

494229990 - Société à responsabilité limitée
Capital : 8 000,00 EUR

Cessation d'activité

Gérant : AGULLO Bruno

9 allée Duquesne 44000 Nantes
28/08/2009

Michel SAUVAGE

498889799 - Société d'exercice libéral A.R.L. unipersonnelle
Capital : 17 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : SAUVAGE Michel Guy

170 rue du Verger 44150 Ancenis
28/08/2009

CABINET DU DOCTEUR NICOLLE

500084454 - Société d'exercice libéral A.R.L.
Capital : 30 000,00 EUR

Augmentation de capital

Gérant : NICOLLE Roland René Paul

3 place Emile Sarradin 44000 Nantes
28/08/2009

TSUNAMO

500739339 - Société par actions simplifiée
Capital : 188 000,00 EUR

Augmentation de capital

Président de la société : VIAUD Pierrick Laurent Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT PARTENAIRES CONSEILS Commissaire aux comptes suppléant : ELATA

1 rue Olivier de Serres Parc d'Activité de la grand'Haie 44119 Grandchamp Des Fontaines
Archives
GONTIER AURORE MARJORIE
RUBE SERVICES
HEALTHCOACH
RUEL ALAIN JEAN ALBERT
SCI COYPEL LE SANCERRE
CUMA ACACIAS