28/08/2009 |
EARL DU PETIT BOIS
381424142 -
E.A.R.L. Capital : 15 244,90 EUR
|
Changement de gérant
Gérant : MOREAU Aline Juliette
lieu-dit la Noé 35130 Moutiers |
|
28/08/2009 |
SODIFRANCE
383139102 -
Société anonyme à directoire Capital : 5 000 000,00 EUR
|
Changement de commissaire aux comptes Changement de membres du conseil de surveillance
Président du directoire : MAZIN Franck Max Francis Président du conseil de surveillance : DERAM Eric Jean Claude Vice-président du conseil de surveillance : ANGOT Bernard Michel Membre du directoire : MAZIN Anne-Laure Catherine Eliane Membre du directoire : LENNON Yves Pierre Membre du directoire : RIVIERE DE PRECOURT Frederic Membre du conseil de surveillance : UNI EXPANSION OUEST Membre du conseil de surveillance : JOUSSET Gérard Membre du conseil de surveillance : CLAVERIE Gérard Membre du conseil de surveillance : SYNERGIE FINANCE GESTION Membre du conseil de surveillance : SODERO GESTION Directeur général : LENNON Yves Pierre Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR GRANT THORNTON Commissaire aux comptes titulaire : SOLIS - MARC DHERBEY & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoît Commissaire aux comptes suppléant : ARPEGE AUDITEURS ASSOCIES
avenue Saint Vincent Parc d'Activité la Bretèche 35760 Saint-Grégoire |
|
28/08/2009 |
SCEA DE LA VALLIERE, SOCIETE EN LIQUIDATION
393070750 -
S.C.E.A. Capital : 30 489,80 EUR
|
Dissolution
Liquidateur amiable : CHAUVEL Jean-Marie Ange Marc
la Basse Foucherie 35500 Vitré |
|
28/08/2009 |
EARL LA HERSONNAIS
417642295 -
E.A.R.L.
|
Transformation de G.A.E.C. en E.A.R.L. Changement de gérant
Gérant : SAUVEE Olivier Michel
la Hersonnais 35630 Vignoc |
|
28/08/2009 |
ATELIER DES SIGNES SARL
392031522 -
Société à responsabilité limitée Capital : 8 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : POUCHIN Olivier Michel Bernard
Z.A. la Gaultière 35220 Châteaubourg |
|
28/08/2009 |
INTER-AVIC
381886696 -
Société en nom collectif Capital : 352 015,75 EUR
|
Réduction du capital Changement de composition des associés
Gérant associé en nom : FRANCE SEXAGE, représenté par M CHAUVEY Joël Pierre Marie Gérant associé en nom : JAOUEN Patrice Louis Marie Associé en nom collectif : HOUSSAY Jean-Pascal Joseph Marie Associé en nom collectif : DANIEL Isabelle Fernande Jeanne Marie Associé en nom collectif : GREGOIRE Gwenaëlle Marie-Annick Gilberte Associé en nom collectif : THOMAS Christine Suzanne Marie Associé en nom collectif : BRETEL Loïc Louis Associé en nom collectif : ROUX Christele Marie Lucienne Associé en nom collectif : GAILLARD Marie-Lea Jeanne Simone Associé en nom collectif : BALAVOINE Claude Jean Baptiste Associé en nom collectif : BARBIER Valérie Jeanne Patricia Associé en nom collectif : LEPINAY Stéphane René Jacques Associé en nom collectif : BOUGUET Fabienne Josette Danielle Associé en nom collectif : CARREE Guylaine Lucienne Yvonne Associé en nom collectif : GAINCHE Christine Anne-Marie Associé en nom collectif : BLAYO Anne-Marie Catherine Dominique Associé en nom collectif : GAUDIN Nadine Aline Rolande Associé en nom collectif : ETRILLARD Géraldine Simone Annick Rose Associé en nom collectif : GAILLARD Nathalie Associé en nom collectif : CAP'ARVEN Associé en nom collectif : EVEILLARD Jean-Luc Associé en nom collectif : BOUESSEL Mickael Associé en nom collectif : FRIN Véronique Associé en nom collectif : BENOIT Benjamin Associé en nom collectif : BERNARD Eric Michel Yves Associé en nom collectif : CALMET Herri Yvonnick Marie Associé en nom collectif : LE SAUX Philippe Associé en nom collectif : BELLIL Lydie Associé en nom collectif : MERCIER Jean Associé en nom collectif : JEGOUIC Jacques Associé en nom collectif : CHEVALLIER Cédric Associé en nom collectif : GEFFROY Marie-Paule Associé en nom collectif : LEBRETON Annie Associé en nom collectif : JUMELAIS Mathieu Associé en nom collectif : RIGAUD Marylène Associé en nom collectif : CORDEROCH Gaëtan Associé en nom collectif : DENOT Alain Associé en nom collectif : LE GOFF Thierry Associé en nom collectif : GAUTIER Véronique Associé en nom collectif : RONDOUIN Philippe Associé en nom collectif : BOCHE Gwendolyne Associé en nom collectif : MAUDUIT Pascale Associé en nom collectif : MICHEL Bernard Associé en nom collectif : COYEN Marie-Therese Associé en nom collectif : HAMON Elodie Associé en nom collectif : GUERY Andre Associé en nom collectif : TOSTIVINT Celine Associé en nom collectif : DANION Arnaud Associé en nom collectif : COUILLAUD Sindy Associé en nom collectif : ZIYAVOV Ziyavoutdine Associé en nom collectif : AFTIS Aresky Associé en nom collectif : LE BELLEGO Gildas Associé en nom collectif : WISNIESKI Kordian Associé en nom collectif : KRAJEWSKI Mateusz Associé en nom collectif : DUHOUX Maud Associé en nom collectif : GARLANTEZEC Romain Commissaire aux comptes titulaire : AMB CONSULTANTS Commissaire aux comptes suppléant : BOUCHEE Philippe
1 rue des Métiers Z.A. du Chesnot 35160 Breteil |
|
28/08/2009 |
EPIGASTRE
487771107 -
Société d'exercice libéral A.R.L. Capital : 30 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : DUDICOURT Jean-Christophe Léon Edmond Gérant : MARION Jean Gérant : PLIHON Geneviève Christine Marie Andrée Gérant : GORLOT Ingrid
8 rue du Chène Germain 35510 Cesson-Sévigné |
|
28/08/2009 |
O2 KID RENNES
511267742 -
S.A.R.L. à associé unique Capital : 1 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant non associé : RICHARD Guillaume
61 rue de Lorient 35000 Rennes |
|
28/08/2009 |
PROCOM
481733954 -
Société en nom personnel
|
Transfert d'établissement principal avec création
Personne infiniment responsable : DUBOIS Yannick, Gilbert, Roland
48 rue Paul Cocteau 37320 Esvres |
|
|
28/08/2009 |
SARL HOTEL DU CYGNE
326168960 -
S.A.R.L. à associé unique Capital : 7 622,45 EUR
|
Changement de gérant Changement de forme
Gérant : HUANG Victor
6 rue du Cygne 37000 Tours |
|
28/08/2009 |
DARINE
398457457 -
Société à responsabilité limitée Capital : 7 622,45 EUR
|
Changement de gérant
Co-gérant : MOREAU Mehdi Denis Sylvain Co-gérant : DEASY Jeanne Alecia
1 rue Etienne Cosson 37170 Chambray-lès-Tours |
|
28/08/2009 |
CONCEPT INTERIEUR
403085194 -
Société à responsabilité limitée Capital : 7 622,45 EUR
|
Changement de gérant
Gérant : DEASY Jeanne Alecia
74 avenue du Grand Sud 37170 Chambray-lès-Tours |
|
28/08/2009 |
TOURS DE CHANT
404565830 -
Société à responsabilité limitée Capital : 7 622,45 EUR
|
Changement de gérant
Gérant : BOISSON DE CHAZOURNES Félix Bruno
45-47 rue Marceau 37000 Tours |
|
28/08/2009 |
FIDUSOFT
411372923 -
Société anonyme à conseil d'administration Capital : 768 000,00 EUR
|
Départ d'un administrateur Changement de président du conseil d'administration et du directeur général
Président du conseil d'administration et directeur général : PONTROUE Benoît Marie Jean Administrateur : VILLAIN Claude Marcel Paul Administrateur : BACHELIER-LUBIN Jacques Marie Henri Commissaire aux comptes titulaire : COULON Alain Commissaire aux comptes suppléant : ALAIN COULON AUDIT CONSEIL
3 bis rue de la Tuilerie 37550 Saint-Avertin |
|
28/08/2009 |
BERNY M & S
420715708 -
Société à responsabilité limitée Capital : 38 112,25 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Co-gérant : GAUGRY Stéphane Roland Roger Co-gérant : BERNY Max Yves Commissaire aux comptes titulaire : CROZON Jean-François Commissaire aux comptes suppléant : CLAUDEL Pierre
la Borde 37110 Monthodon |
|
28/08/2009 |
TRANS LOIRE EXPRESS
421994583 -
Société à responsabilité limitée Capital : 11 128,78 EUR
|
Changement de gérant
Gérant : MOREAU Edith Raymonde
7 avenue de la Loire Z I les Poujeaux 37530 Nazelles-Négron |
|
28/08/2009 |
INTERPOOL RESEAU
431235258 -
Société par actions simplifiée Capital : 62 000,00 EUR
|
Changement de président de S.A.S.
Président de la société : RAVIER Thierry Maurice Administrateur : SAINT-JEAN Didier René Fernand Administrateur : ISELIN Vincent Administrateur : SELLIER Claude Eugène Administrateur : BENITO Bernard Francis Administrateur : BIGONNEAU Alain Patrick Pierre Commissaire aux comptes titulaire : JEHANNO Dominique Commissaire aux comptes suppléant : CARMENT Antoine
rue Gaspard Monge Z.A.C. de Conneuil 37270 Montlouis-sur-Loire |
|
28/08/2009 |
VOLTERAM
315905141 -
Société à responsabilité limitée Capital : 150 000,00 EUR
|
Augmentation de capital
Gérant : LERICHE Laurent Luc Josselin
Z I la Coudrière 37210 Parçay-Meslay |
|
28/08/2009 |
HBED
441568581 -
Société à responsabilité limitée Capital : 9 000,00 EUR
|
Départ de co-gérant Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : DEASY Jeanne Alecia
Mon Idée 37800 Saint-Epain |
|
|
28/08/2009 |
BLEU MARINE LOC
445353089 -
Société à responsabilité limitée Capital : 8 000,00 EUR
|
Changement d'activité Changement de forme
Gérant : LE POUPON Denis Jacques Franco
le Poirier la Belle 37210 Rochecorbon |
|
28/08/2009 |
MV.COURTAGE
449167170 -
Société à responsabilité limitée Capital : 7 800,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : LELARGE Willy Frédéric Gérard
31 rue du Bois Bouquin 37110 Chateau Renault |
|
28/08/2009 |
VERSUS STATION
482809050 -
Société à responsabilité limitée Capital : 6 000,00 EUR
|
Cessation d'activité avec dissolution
Liquidateur amiable : SPIES Laurent Guy
16 rue des Trois Ecritoires 37000 Tours |
|
28/08/2009 |
A.M.I. RAYONNAGE
484035878 -
S.A.R.L. à associé unique Capital : 10 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement d'activité
Gérant : ODILLE Franck
15 rue de la Gratiole Z.I. les Brosses N°2 37270 Larçay |
|
28/08/2009 |
CEF BOISSONS
492188487 -
Société à responsabilité limitée Capital : 30 000,00 EUR
|
Augmentation de capital Changement de gérant Changement d'activité
Gérant : FIGUEIREDO Philippe Michel
7 rue les Terrages 37390 Saint Roch |
|
28/08/2009 |
ESPACE BLANC NATURE
493677678 -
Société à responsabilité limitée Capital : 12 000,00 EUR
|
Changement de gérant Nomination d'un co-gérant
Co-gérant : BAILLET Jean-Yves Michel Marie Co-gérant : ROUSSEAU Laurence Marie Danielle
28 rue Picois 37600 Loches |
|
28/08/2009 |
GALAPAT'S
500366737 -
Société à responsabilité limitée Capital : 8 000,00 EUR
|
Cessation d'activité avec dissolution
Liquidateur amiable : VAZELLE Patrick Jean-Pierre
9 rue Jules Charpentier 37000 Tours |
|
28/08/2009 |
ECO-ENERGIES TOURAINE
509140422 -
Société à responsabilité limitée Capital : 5 000,00 EUR
|
Changement de gérant
Co-gérant : DHORMES Nicolas Alphonse André Co-gérant : ERAUD Agnès Marcelle Co-gérant : DEASY Jeanne Alecia
74 avenue du Grand Sud 37170 Chambray-lès-Tours |
|
28/08/2009 |
MOREL RECUPERATION FERRAILLE METAUX EPAVE
344962931 -
Société en nom personnel
|
Changement d'activité
Personne infiniment responsable : MOREL Pascal
rue du Haut Mas 42150 La Ricamarie |
|
28/08/2009 |
GOBAT
433906724 -
Société en nom personnel
|
Changement de nom commercial
Personne infiniment responsable : GOKSEN Kadir
19 rue de la République 42500 Le Chambon-Feugerolles |
|
|
28/08/2009 |
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARBAUD
340700624 -
Société civile immobilière Capital : 762,25 EUR
|
Cessation d'activité avec dissolution
Liquidateur amiable : LANION Martine
71-73 la Malafolie 42500 Le Chambon-Feugerolles |
|
28/08/2009 |
LE TOIT FOREZIEN
574501714 -
Société coopérative d'intérêt collectif anonyme Capital : 42 134,40 EUR
|
Changement de directeur général Nomination du directeur général délégué.
Président du conseil d'administration : HENRY Jacky Yves Michel Directeur général : MATTIUSSI Mario Directeur général délégué : ODOUARD François Marie Jean Administrateur : PINET Daniel Administrateur : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, représenté par M ZENNAF Kahier Administrateur : UNION DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS C.G.T., représenté par MLE VALLA Martine Administrateur : UNION DEPARTEMENTAL SYNDICATS C.F.D.T., représenté par MME PEYRARD Claude Marie Jeanne Administrateur : 1% LOGEMENT LOIRE Administrateur : CREDIT COOPERATIF, représenté par M AVO José Antonio Administrateur : BONIFAT Michel Administrateur : CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT, représenté par MME SCHOPPIG Myriam Administrateur : FARLAY Jean Claude Antoine Administrateur : SAINT ETIENNE METROPOLE, représenté par M BOUTHEON Henry Michel Administrateur : MONNET Marie Claude Eugénie Louise Administrateur : UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO, représenté par MME ORIOL Bernadette Administrateur : CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES CSF, représenté par M DOPPLER François Louis Marie Administrateur : YAHYA Driss Administrateur : PACT LOIRE, représenté par M HERRGOTT Antoine Pierre Administrateur : DAHMANI Marylène Administrateur : AIT MANSOUR Alexandre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROYET Commissaire aux comptes suppléant : TRIOLLIER Daniel
29 rue jo Gouttebarge 42000 Saint-Etienne |
|
28/08/2009 |
PISCINE FACILE
494843592 -
Société à responsabilité limitée Capital : 2 100,00 EUR
|
Changement de gérant Transformation en société à responsabilité limitée
Gérant : RIVOLLIER Jérôme Joseph Joël
le Communal 42210 Marclopt |
|
28/08/2009 |
CASINO DE MONTROND LES BAINS
885550327 -
Société par actions simplifiée Capital : 459 000,00 EUR
|
Changement de commissaire aux comptes
Président : BRUYERE Michel Joseph Alexandre Directeur général : FOREST-DODELIN Laurent Pierre Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
route de Roanne 42210 Montrond-les-Bains |
|
28/08/2009 |
SCI I.V.V.
452289069 -
Société civile Capital : 600,00 EUR
|
Départ de co-gérant Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : HOUG Didier Associé : HOUG Didier Associé : PRALONG Paulette Rosalie Sylvie
16 allée des Myosotis 42340 Veauche |
|
28/08/2009 |
MP STUDIO
513409151 -
Société à responsabilité limitée Capital : 1 000,00 EUR
|
Mise en activité suite à création
Co-gérant : ROLLE Priscilla Co-gérant : LAINSER Monia
6 rue Louis Merley 42000 Saint-Etienne |
|
28/08/2009 |
CONSTRUCTIONS METALLIQUES RICHARD
311262703 -
Société par actions simplifiée Capital : 364 100,00 EUR
|
Augmentation de capital
Président de la société : RICHARD Louis Paul Francis Marie Commissaire aux comptes titulaire : NICOL PELE BRODU Commissaire aux comptes suppléant : BRODU Guy
25 rue du Vignoble 44330 La Chapelle-Heulin |
|
28/08/2009 |
OCABURO
327796884 -
Société anonyme à directoire Capital : 203 455,00 EUR
|
Augmentation de capital
Président du directoire : BLANCHET DHUISMES François Christian Président du conseil de surveillance : BLANCHET DHUISMES Jean-François Vice-président du conseil de surveillance : BLANCHET-DHUISME Valérie Florence Membre du directoire : BLANCHET-DHUISMES Virginie Hélène Jeanne Membre du conseil de surveillance : URIARTE Chantale Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS Commissaire aux comptes suppléant : CHAPISEAU Alain
les Piliers de la Chauvinière 44800 Saint Herblain |
|
28/08/2009 |
EARL DE LA MABONNIERE
334958394 -
E.A.R.L. Capital : 45 000,00 EUR
|
Réduction du capital
Gérant : PEIGNE Michel Joseph
la Mabonnière 44150 Oudon |
|
28/08/2009 |
ALFA.SAFETY
405100587 -
Société à responsabilité limitée Capital : 295 092,12 EUR
|
Augmentation de capital
Gérant : BOISSON Jean-Paul Roger Marie
15 rue Lamoricière 44100 Nantes |
|
|
28/08/2009 |
JEFCO DEVELOPPEMENT
438388621 -
Société à responsabilité limitée Capital : 1 150,00 EUR
|
Réduction du capital
Gérant : DESHAYES Jean-François Charles
18 avenue de Langeais 44800 Saint Herblain |
|
28/08/2009 |
ABALONE TT 49-85
440268589 -
Société à responsabilité limitée Capital : 40 000,00 EUR
|
Changement de commissaire aux comptes
Gérant : MOUTEL Francois-Xavier Bernard Guy Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes suppléant : CO-PILOTES
7 ter boulevard Allard 44000 Nantes |
|
28/08/2009 |
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA FAMILLE GIRAUDEAU-PATRON
441441599 -
Groupement foncier agricole Capital : 38 308,00 EUR
|
Réduction du capital
Associé indéfiniment responsable : PATRON Janine Co-gérant associé indéfiniment responsable : PATRON Joseph Alexandre Jean Co-gérant associé indéfiniment responsable : GIRAUDEAU Jean-Pierre Armand Joseph Léon Co-gérant associé indéfiniment responsable : GIRAUDEAU Daniel Denis Bernard Marie
le Petit Logis Pont James 44310 Saint Colomban |
|
28/08/2009 |
ATN OUEST
451724652 -
Société par actions simplifiée Capital : 50 000,00 EUR
|
Changement de commissaire aux comptes
Président de la société : MIYX Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : VOLLE Christian Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT MAISONNEUVE
11 rue du chemin Rougé Centre Exalis - Batiment E 44300 Nantes |
|
28/08/2009 |
ATN OUEST
451724652 -
Société par actions simplifiée Capital : 50 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Président de la société : MIYX Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : VOLLE Christian Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT MAISONNEUVE
11 rue du chemin Rougé Centre Exalis - Batiment E 44300 Nantes |
|
28/08/2009 |
ALTEA FINANCES
414324699 -
Société par actions simplifiée Capital : 3 165 000,00 EUR
|
Augmentation de capital
Président de la société : MEVEL Fabien Directeur général : ROZE Benoît Jean Michel Commissaire aux comptes titulaire : EXCO BRETAGNE - A.B.O. Commissaire aux comptes suppléant : GAUDE Alain
153 route des Sorinières 44400 Rezé |
|
28/08/2009 |
SCI DAOUDAL
453610065 -
Société civile immobilière Capital : 1 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Déclaration des nouveaux associés
Associé indéfiniment responsable : DAOUDAL Anne-Gaëlle Jeanne Associé indéfiniment responsable : DAOUDAL Solène Dominique Gérant associé indéfiniment responsable : DAOUDAL René Jean Pierre
17 rue Russeil 44000 Nantes |
|
28/08/2009 |
SARL CAS
494229990 -
Société à responsabilité limitée Capital : 8 000,00 EUR
|
Cessation d'activité
Gérant : AGULLO Bruno
9 allée Duquesne 44000 Nantes |
|
28/08/2009 |
Michel SAUVAGE
498889799 -
Société d'exercice libéral A.R.L. unipersonnelle Capital : 17 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : SAUVAGE Michel Guy
170 rue du Verger 44150 Ancenis |
|
28/08/2009 |
CABINET DU DOCTEUR NICOLLE
500084454 -
Société d'exercice libéral A.R.L. Capital : 30 000,00 EUR
|
Augmentation de capital
Gérant : NICOLLE Roland René Paul
3 place Emile Sarradin 44000 Nantes |
|
28/08/2009 |
TSUNAMO
500739339 -
Société par actions simplifiée Capital : 188 000,00 EUR
|
Augmentation de capital
Président de la société : VIAUD Pierrick Laurent Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT PARTENAIRES CONSEILS Commissaire aux comptes suppléant : ELATA
1 rue Olivier de Serres Parc d'Activité de la grand'Haie 44119 Grandchamp Des Fontaines |
|