Date Société Description Liens
31/10/2009

SEQUOIA

494565864 - Société à responsabilité limitée
Capital : 8 000,00 EUR

Dissolution anticipée de la société

Liquidateur amiable : LONGERE Dominique Fabrice

la Côte Maréchal 42470 Neaux
31/10/2009

MIWI IMMOBILIER

497703439 - Société civile
Capital : 600,00 EUR

Changement de gérant

Gérant associé indéfiniment responsable : MERIEUX Stéphane Paul Raymond Marie Associé indéfiniment responsable : ESPRIT Marie France Geneviève Jeanne Associé indéfiniment responsable : MERIEUX Henry-Louis Marie François

Z.I. 19 boulevard Charles de Gaulle 42120 Le Coteau
31/10/2009

ESPRIMEDIA

500926118 - Société coopérative de production A.R.L. à capital variable
Capital : 1 200,00 EUR

Changement de gérant

Gérant : BOURLON Véronique

55 rue Michel Devillaine 42300 Roanne
31/10/2009

EXP'EAU LOGISTIC

503104895 - Société à responsabilité limitée
Capital : 120 000,00 EUR

Transfert SSET Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : GERY Vincent Philippe Marie Daniel

Z.A.C. des Grandes Terres 42260 Saint-Germain-Laval
31/10/2009

COCO CREME

504497017 - Société en nom collectif
Capital : 50 000,00 EUR

Adjonction objet et activité

Gérant associé en nom : REN Yueshen Associé en nom collectif : WANG Xiaohui

1 place Georges Clémenceau 42300 Roanne
31/10/2009

ULTRA NOVA

505024539 - Société par actions simplifiée
Capital : 1 000 000,00 EUR

Augmentation capital, nomination directeur général Augmentation de capital Nomination de directeur général

Président de la société : DORING Gerhard Wolfgang Directeur général : WALTZ Claude Ernest Commissaire aux comptes titulaire : MAUREL Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : BELUZE Pierre

168 rue de Charlieu 42300 Roanne
31/10/2009

CREARBORIS

485357735 - S.A.R.L. à associé unique
Capital : 8 000,00 EUR

Changement objet Changement de l'objet et de l'activité

Gérant : CHABRY Alexis

le Bourg 42370 Les Noës
31/10/2009

1 TAHITI 2009

509836755 - Société en nom collectif
Capital : 114 803,00 EUR

Augmentation de capital Augmentation de capital

Gérant associé en nom : PACIFIQUE FINANCE PARTICIPATION-1 Associé en nom collectif : DB - 1, représenté par M DE BREBISSON Christophe Thierry Marie Associé en nom collectif : DEVOUCOUX Arnaud Philippe Joseph Associé en nom collectif : CROUE François Michel Jean Associé en nom collectif : MAYNARD Annie Associé en nom collectif : ARTAUD Alain Roger Associé en nom collectif : MENSIER Eric Alain Associé en nom collectif : ROTENBERG Maxime Associé en nom collectif : SIMON Patrick David Associé en nom collectif : MOUGENOT Gérard Robert Associé en nom collectif : FAURE Régis Associé en nom collectif : VALDIGUIE Marc Jacques Louis Marie Associé en nom collectif : FREY Marguerite Associé en nom collectif : BERNADIN Pierre François Claude Associé en nom collectif : ROMEU Virginie Caroline Associé en nom collectif : CANTENOT Christian Max André Associé en nom collectif : DE VERDELHAN DES MOLLES Marc François Associé en nom collectif : DUPOIZAT Arnauld Philippe Frédéric Associé en nom collectif : FAYARD Franck Nicolas Michel Associé en nom collectif : GOUT Christian Pierre Associé en nom collectif : ARLECCHINI Marie France Associé en nom collectif : PERRAULT André Associé en nom collectif : ROLAND Associé en nom collectif : RUSTHUL Arnaud Max Associé en nom collectif : RUSTHUL Jean Etienne Associé en nom collectif : TOLLON Christophe Jean Marie Hubert Associé en nom collectif : KILBY David Leslie

2 rue des Mariniers 42120 Le Coteau
31/10/2009

1 BORA BORA 2009

509836672 - Société en nom collectif
Capital : 113 633,00 EUR

Augmentation de capital

Gérant associé en nom : PACIFIQUE FINANCE PARTICIPATION-1 Associé en nom collectif : DB - 1, représenté par M DE BREBISSON Christophe Thierry Marie Associé en nom collectif : DEVOUCOUX Arnaud Philippe Joseph Associé en nom collectif : CROUE François Michel Jean Associé en nom collectif : MAYNARD Annie Associé en nom collectif : ARTAUD Alain Roger Associé en nom collectif : MENSIER Eric Alain Associé en nom collectif : ROTENBERG Maxime Associé en nom collectif : SIMON Patrick David Associé en nom collectif : MOUGENOT Gérard Robert Associé en nom collectif : FAURE Régis Associé en nom collectif : VALDIGUIE Marc Jacques Louis Marie Associé en nom collectif : FREY Marguerite Associé en nom collectif : BERNADIN Pierre François Claude Associé en nom collectif : ROMEU Virginie Caroline Associé en nom collectif : CANTENOT Christian Max André Associé en nom collectif : DE VERDELHAN DES MOLLES Marc François Associé en nom collectif : DUPOIZAT Arnauld Philippe Frédéric Associé en nom collectif : FAYARD Franck Nicolas Michel Associé en nom collectif : GOUT Christian Pierre Associé en nom collectif : ARLECCHINI Marie France Associé en nom collectif : PERRAULT André Associé en nom collectif : ROLAND Associé en nom collectif : RUSTHUL Arnaud Max Associé en nom collectif : RUSTHUL Jean Etienne Associé en nom collectif : TOLLON Christophe Jean Marie Hubert Associé en nom collectif : KILBY David Leslie

2 rue des Mariniers 42120 Le Coteau
31/10/2009

1 MOOREA 2009

509816765 - Société en nom collectif
Capital : 112 744,00 EUR

augmentation de capital Augmentation de capital

Gérant associé en nom : PACIFIQUE FINANCE PARTICIPATION-1 Associé en nom collectif : DB - 1, représenté par M DE BREBISSON Christophe Thierry Marie Associé en nom collectif : DEVOUCOUX Arnaud Philippe Joseph Associé en nom collectif : CROUE François Michel Jean Associé en nom collectif : MAYNARD Annie Associé en nom collectif : ARTAUD Alain Roger Associé en nom collectif : MENSIER Eric Alain Associé en nom collectif : ROTENBERG Maxime Associé en nom collectif : SIMON Patrick David Associé en nom collectif : MOUGENOT Gérard Robert Associé en nom collectif : FAURE Régis Associé en nom collectif : VALDIGUIE Marc Jacques Louis Marie Associé en nom collectif : FREY Marguerite Associé en nom collectif : BERNADIN Pierre François Claude Associé en nom collectif : ROMEU Virginie Caroline Associé en nom collectif : CANTENOT Christian Max André Associé en nom collectif : DE VERDELHAN DES MOLLES Marc François Associé en nom collectif : DUPOIZAT Arnauld Philippe Frédéric Associé en nom collectif : FAYARD Franck Nicolas Michel Associé en nom collectif : GOUT Christian Pierre Associé en nom collectif : ARLECCHINI Marie France Associé en nom collectif : PERRAULT André Associé en nom collectif : ROLAND Associé en nom collectif : RUSTHUL Arnaud Max Associé en nom collectif : RUSTHUL Jean Etienne Associé en nom collectif : TOLLON Christophe Jean Marie Hubert Associé en nom collectif : KILBY David Leslie

2 rue des Mariniers 42120 Le Coteau
31/10/2009

1 HUAHINE 2009

509806865 - Société en nom collectif
Capital : 112 528,00 EUR

Augmentation de capital Augmentation de capital

Gérant associé en nom : PACIFIQUE FINANCE PARTICIPATION-1 Associé en nom collectif : DB - 1, représenté par M DE BREBISSON Christophe Thierry Marie Associé en nom collectif : DEVOUCOUX Arnaud Philippe Joseph Associé en nom collectif : CROUE François Michel Jean Associé en nom collectif : MAYNARD Annie Associé en nom collectif : ARTAUD Alain Roger Associé en nom collectif : MENSIER Eric Alain Associé en nom collectif : ROTENBERG Maxime Associé en nom collectif : SIMON Patrick David Associé en nom collectif : MOUGENOT Gérard Robert Associé en nom collectif : FAURE Régis Associé en nom collectif : VALDIGUIE Marc Jacques Louis Marie Associé en nom collectif : FREY Marguerite Associé en nom collectif : BERNADIN Pierre François Claude Associé en nom collectif : ROMEU Virginie Caroline Associé en nom collectif : CANTENOT Christian Max André Associé en nom collectif : DE VERDELHAN DES MOLLES Marc François Associé en nom collectif : DUPOIZAT Arnauld Philippe Frédéric Associé en nom collectif : FAYARD Franck Nicolas Michel Associé en nom collectif : GOUT Christian Pierre Associé en nom collectif : ARLECCHINI Marie France Associé en nom collectif : PERRAULT André Associé en nom collectif : RUSTHUL Arnaud Max Associé en nom collectif : RUSTHUL Jean Etienne Associé en nom collectif : TOLLON Christophe Jean Marie Hubert Associé en nom collectif : KILBY David Leslie Associé en nom collectif : ROLAND

2 rue des Mariniers 42120 Le Coteau
31/10/2009

EASTCOM

510805633 - Société à responsabilité limitée
Capital : 6 000,00 EUR

Transfert du siège et établissement principal

Gérant : DUFOUR Jérémie

27 rue Langenieux 42300 Roanne C
31/10/2009

R.C.L.

510942337 - Société à responsabilité limitée
Capital : 8 340,00 EUR

Augmentation de capital

Gérant : LEGER Ludovic Jean François Michel

280 avenue Charles de Gaulle 42153 Riorges
31/10/2009

LPB CONSTRUCTION

511917486 - S.A.R.L. à associé unique
Capital : 2 000,00 EUR

Changement de nom commercial et transfert du siège et établissement principal

Gérant : ZINK Pierrick Edouard

lieu-dit la Côte Maréchal 42470 Neaux
31/10/2009

RANE

513024091 - Société en nom collectif
Capital : 10 000,00 EUR

Nomination de co-gérants Nomination de co-gérants

Co-gérant associé en nom : P. M. DIS Co-gérant associé en nom : CAUDRELIER Aline Gisèle Co-gérant associé en nom : RECHATIN Céline Catherine Janyck Co-gérant associé en nom : DESNOS Christelle

rue de l'Artisanat 42300 Mably
31/10/2009

AMBULANCE - GESTION ET DEVELOPPEMENT A.G.D.

513251454 - Société à responsabilité limitée
Capital : 6 000,00 EUR

Transfert siège Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement d'activité

Co-gérant : PARDON Loïc Co-gérant : BELLONI Alexandre Bruno Co-gérant : DESMURS Florian Co-gérant : GONDRAS Sébastien

18 ter avenue du Polygone 42300 Roanne
31/10/2009

CONCEPT@PC

514125616 - Société à responsabilité limitée
Capital : 5 100,00 EUR

Mise en activité suite création

Gérant : MORILLA André Jean-François

rue de la Croix Sotton 42460 Coutouvre
31/10/2009

GROUPE MADO

514158062 - Société par actions simplifiée
Capital : 1 290 000,00 EUR

L'établissement secondaire devient établissement principal

Président de la société : PACHA, représenté par M LEONETTI Bernard Marcel Directeur général : DOUILLET Caroline Marie Bernadette Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA Commissaire aux comptes suppléant : EPINAT Jean-Pierre

rn7 lieu-dit la Croix 42470 Neaux
31/10/2009

DESLOIR Laurent, Bernard, André

508329075 - Société en nom personnel

Transfert d'établissement principal avec création Changement d'activité

Personne infiniment responsable : DESLOIR Laurent, Bernard, André

7 rue Louis Charles Bréguet 42160 Andrézieux-Bouthéon
31/10/2009

S.C.I. MARTIN

334667102 - Société civile immobilière
Capital : 2 286,74 EUR

Changement de gérant

Gérant : CALLET François Pierre Marie Associé : MARTIN Josiane Associé : CALLET François Pierre Marie

6 route de la Varizelle 42400 Saint-Chamond
31/10/2009

SOGESER

323902288 - Société civile
Capital : 1 372,04 EUR

Cessation d'activité avec dissolution

Liquidateur amiable : SERTILLANGE André Barthélémy Noël

120 avenue Albert Raimond 42270 Saint-Priest-en-Jarez
31/10/2009

SEDOS CONSEIL

391196706 - Société d'exercice libéral de forme anonyme
Capital : 168 000,00 EUR

Changement de dénomination sociale Nomination d'un directeur général délégué

Président du conseil d'administration : GOUGEON Anne Denise Jacqueline Directeur général : GOUGEON Anne Denise Jacqueline Directeur général délégué : ALLIROT Martine Jeanne Directeur général délégué : VILLE Willy Yves Gilbert Directeur général délégué : COCHERIL Arnaud Charles Guillaume Administrateur : COCHET Jean Pierre Paul Louis Administrateur : ALLIROT Martine Jeanne Administrateur : GOUGEON Anne Denise Jacqueline Commissaire aux comptes titulaire : FAURY Didier Commissaire aux comptes suppléant : CREUSAT Didier

145 rue de la Montat 5 A 9 allée du Pont de l'Ane 42000 Saint-Etienne
31/10/2009

FERRIOL-MATRAT INVESTISSEMENTS

423501055 - Société à responsabilité limitée
Capital : 343 200,00 EUR

Augmentation de capital

Gérant : FERRIOL Jean Paul Camille

22 rue de la Croix de Mission Z.I. Croix de Mission 42100 Saint-Etienne
31/10/2009

ARCURI

490916871 - Société civile immobilière
Capital : 3 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Co-gérant : ARCURI Giuseppe Calogero Co-gérant : ARCURI Michel Associé : ARCURI Giuseppe Calogero Associé : ARCURI Michel

16 rue Jean Sébastien Bach 42000 Saint-Etienne
31/10/2009

DESCHAMPS ELECTRICITE

504822701 - S.A.R.L. à associé unique
Capital : 2 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : DESCHAMPS Jean Christophe

lieu-dit les Ombres 42660 Saint-Genest-Malifaux
31/10/2009

EXPERTIZ SANTE

432643922 - S.A.R.L. à associé unique
Capital : 20 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : VERGNAUD Stéphane

9 rue Aristide Briand 42160 Andrézieux-Bouthéon
31/10/2009

GILANNE

435275383 - Société civile immobilière
Capital : 2 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Co-gérant : CRESCI Gilles Co-gérant : CRESCI Anne Co-gérant : CRESCI Rolland Associé : CRESCI Gilles Associé : CRESCI Anne Associé : CRESCI Rolland

15 rue Jean Claude Verpilleux 42000 Saint-Etienne
31/10/2009

PARM

453373342 - Société à responsabilité limitée
Capital : 2 000,00 EUR

Changement de gérant

Gérant : MARTIN Johanna

353 route de Bellegarde 42330 Cuzieu
31/10/2009

COURAT ET ASSOCIES

392792354 - Société par actions simplifiée
Capital : 40 000,00 EUR

Nomination de directeur général

Président : COURAT Jean Noël Directeur général : POULARD Frédéric François Robert Directeur général : FONSALE Didier Alain Jean Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BOREL ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : FRESSE Jean Paul

30 boulevard de l'Hippodrome 42110 Feurs
31/10/2009

FINANCIERE CPF

481202562 - Société à responsabilité limitée
Capital : 600 000,00 EUR

Nomination d'un co-gérant

Co-gérant : POULARD Frédéric François Robert Co-gérant : COURAT Jean Noël Co-gérant : FONSALE Didier Alain Jean

30 boulevard de l'Hippodrome 42110 Feurs
31/10/2009

BECOFER RHONE-ALPES AUVERGNE

509761813 - Société à responsabilité limitée
Capital : 2 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : LENOIR Nicolas Raymond

26 rue de la République 42440 Noirétable
31/10/2009

C.CHOCOLAT

509453973 - Société en nom personnel

Changement d'activité

Personne infiniment responsable : HAZO Christiane, Andree

9 rue du Minage 44190 Clisson
31/10/2009

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN)

314684960 - S.A. d'économie mixte
Capital : 600 000,00 EUR

Changement d'administrateur nomination de l'union départementale de la confédération syndicale des familles de loireatlantique représentée par M GASNIER Jean, en remplacement de l'association locale de la consommation du logement et du cadre de vie

Président du conseil d'administration : NANTES METROPOLE - communauté urbaine..., représenté par M LEMASLE Jean-Pierre Auguste Vice-président : RETIERE Jean-François Marie Vice-président : GOULLET DE RUGY François Henri Vice-président : HIERNARD Hugues Raymond André Directeur général : BOESWILLWALD Alain Jean-Pierre René Administrateur : CHAMBRE DE COMM. ET D'INDUSTRIE NANTES.., représenté par M MOREAU Philippe Administrateur : DURAND Camille Louis Administrateur : TRANSDEV - STE EUROPENNE POUR LE...*, représenté par M CHAPUT Francis Administrateur : MAHE Albert Marcel Auguste André Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAG, représenté par M PATAULT Didier Bernard Gérard Administrateur : UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECOVEC Commissaire aux comptes suppléant : LECLAIR Gilles

3 rue Bellier 44000 Nantes
31/10/2009

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES CORMORANS

348198425 - Société civile immobilière
Capital : 15 244,90 EUR

Changement de gérant

Associé indéfiniment responsable : MAPI Gérant associé indéfiniment responsable : PAYRAUDEAU Marc Michel Daniel

104 rue de Leinster 44240 La Chapelle-sur-Erdre
31/10/2009

L'ECLAIREUR

378792154 - Société par actions simplifiée
Capital : 305 000,00 EUR

Cessation d'activité avec dissolution

Président de la société : GAUNAND Francis Daniel Gilbert Commissaire aux comptes titulaire : LHOMMEAU Philippe Commissaire aux comptes suppléant : EXCO ATLANTIQUE

44 rue Aristide Briand 44110 Châteaubriant
31/10/2009

LES 3 MOULINS

379273287 - Société par actions simplifiée
Capital : 130 000,00 EUR

Transformation en société par actions simplifiée

Président de la société : VINET Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : SNR CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : ANREP Gérard

la Brosse Ténaud 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
31/10/2009

SCI DE LARMINAT

383720794 - Société civile
Capital : 1 000,00 EUR

Réduction du capital Changement de composition des associés

Gérant : BONNEAU Alain Noël Aristide Associé indéfiniment responsable : BONNEAU Yannick Aristide René Marie Associé indéfiniment responsable : LBI FRANCE Associé indéfiniment responsable : BONNEAU Alexandre Marie

Port Jean la Buraudière 44470 Carquefou
31/10/2009

DATALLIANCE

385176607 - S.A.S. unipersonnelle
Capital : 38 113,00 EUR

Transformation en société par actions simplifiée Changement de dénomination sociale changement de président dans une société par actions simplifié

Président de la société : SODIFRANCE Commissaire aux comptes titulaire : SOLIS - MARC DHERBEY & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BLANCHARD Bernard

4 rue du Chateau de l'Eraudière 44300 Nantes
31/10/2009

SCI LE BOIS MARTINEAU

401246665 - Société civile
Capital : 762,25 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Associé indéfiniment responsable : GRENON Loïc Joseph Gérant associé indéfiniment responsable : GRANGER Nicole Marie

2 boulevard François Blancho 44200 Nantes
31/10/2009

KdB ISOLATION

410948186 - Société anonyme à conseil d'administration
Capital : 66 096,00 EUR

Changement d'administrateur

Président du conseil d'administration et directeur général : ERAUD Benoît Laurent Administrateur : DELANOS Jean-Pierre Francis Administrateur : GROUPE INVEST, représenté par MME BALEY Frédérique Commissaire aux comptes titulaire : BOLLORE Claude Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : RSM SECOVEC Commissaire aux comptes suppléant : BLANCHE Anne

2 rue Fernand Pelloutier 44300 Nantes
31/10/2009

AGENCE COMMERCIALE BOUYER JOUBERT

421782624 - Société à responsabilité limitée
Capital : 436 240,00 EUR

Changement de co-gérant

Gérant : BOUYER Nicolas Yves

431 rue Louis Lumière 44430 Le Loroux-Bottereau
31/10/2009

AGENCE COMMERCIALE BOUYER JOUBERT

421782624 - Société à responsabilité limitée
Capital : 436 240,00 EUR

Changement de forme Changement de gérant Réduction du capital

Gérant : BOUYER Nicolas Yves

431 rue Louis Lumière 44430 Le Loroux-Bottereau
31/10/2009

SARL 3 M SERVICES

437651011 - S.A.R.L. à associé unique
Capital : 40 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : VISONNEAU Pierre Louis Paul Serge

7 rue Bélouga Parc d'Activités du Chaffault 44340 Bouguenais
31/10/2009

HM&3J

480223288 - Société par actions simplifiée
Capital : 8 506 205,00 EUR

Augmentation de capital

Président de la société : HAMON Fabrice Jean-Jacques Luc Directeur général : HAMON Jean-Philippe Yves Louis Commissaire aux comptes titulaire : BOMY Jean-Pierre Jack Joseph Commissaire aux comptes suppléant : FRADIN Françoise

42 rue du Onze Novembre 44110 Châteaubriant
31/10/2009

NANTES EST AUTOS

492005343 - Société à responsabilité limitée
Capital : 10 000,00 EUR

Changement de gérant

Gérant : CAMUS Nicolas Georges Martin

1 rue des Luthiers 44700 Orvault
31/10/2009

A. BANIEL CONSULTING

497916247 - Société à responsabilité limitée
Capital : 20 000,00 EUR

Changement de gérant

Gérant : BANIEL Claudie Marie Isabelle

14 rue de l'Orée du Bourg 44880 Sautron
31/10/2009

SARL LAPODE

499868248 - Société à responsabilité limitée
Capital : 1 468 000,00 EUR

Réduction du capital

Co-gérant : LARCHE Grégoire Yves Gilles Co-gérant : PODGORSKI Jean-Pierre

rue de la Fontaine Grillée Zone Artisanale du Pâtis 44690 La Haie-Fouassière
31/10/2009

VICTORY

484232475 - Société par actions simplifiée
Capital : 40 000,00 EUR

changement de président dans une société par actions simplifié Changement de commissaire aux comptes

Président de la société : DESVERONNIERES Philippe Pierre Commissaire aux comptes titulaire : ARNAUD Guy Commissaire aux comptes suppléant : ORAIN Philippe

8 rue du Pré Roux 44120 Vertou
31/10/2009

F.T.G.C.

503047490 - Société à responsabilité limitée
Capital : 60 000,00 EUR

Augmentation de capital

Gérant : METENIER Pascal Olivier

1 rue Charles Lindbergh l'Aéropole 44340 Bouguenais
31/10/2009

SIMELI

504252081 - Société à responsabilité limitée
Capital : 10 000,00 EUR

Démission d'un co-gérant Changement de gérant

Gérant : AUBRON Aurélie Marie Lucie Yvette

2 boulevard Amiral Courbet 44000 Nantes
Archives
GANDRE ERIC
PILARCZYK PEGGY
TAVERNIER SUZON
NGO BILLONG CABAL ANGELE
SCI EGLY-ROSE
SCI DU BAILLY