31/10/2009 |
SEQUOIA
494565864 -
Société à responsabilité limitée Capital : 8 000,00 EUR
|
Dissolution anticipée de la société
Liquidateur amiable : LONGERE Dominique Fabrice
la Côte Maréchal 42470 Neaux |
|
31/10/2009 |
MIWI IMMOBILIER
497703439 -
Société civile Capital : 600,00 EUR
|
Changement de gérant
Gérant associé indéfiniment responsable : MERIEUX Stéphane Paul Raymond Marie Associé indéfiniment responsable : ESPRIT Marie France Geneviève Jeanne Associé indéfiniment responsable : MERIEUX Henry-Louis Marie François
Z.I. 19 boulevard Charles de Gaulle 42120 Le Coteau |
|
31/10/2009 |
ESPRIMEDIA
500926118 -
Société coopérative de production A.R.L. à capital variable Capital : 1 200,00 EUR
|
Changement de gérant
Gérant : BOURLON Véronique
55 rue Michel Devillaine 42300 Roanne |
|
31/10/2009 |
EXP'EAU LOGISTIC
503104895 -
Société à responsabilité limitée Capital : 120 000,00 EUR
|
Transfert SSET Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : GERY Vincent Philippe Marie Daniel
Z.A.C. des Grandes Terres 42260 Saint-Germain-Laval |
|
31/10/2009 |
COCO CREME
504497017 -
Société en nom collectif Capital : 50 000,00 EUR
|
Adjonction objet et activité
Gérant associé en nom : REN Yueshen Associé en nom collectif : WANG Xiaohui
1 place Georges Clémenceau 42300 Roanne |
|
31/10/2009 |
ULTRA NOVA
505024539 -
Société par actions simplifiée Capital : 1 000 000,00 EUR
|
Augmentation capital, nomination directeur général Augmentation de capital Nomination de directeur général
Président de la société : DORING Gerhard Wolfgang Directeur général : WALTZ Claude Ernest Commissaire aux comptes titulaire : MAUREL Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : BELUZE Pierre
168 rue de Charlieu 42300 Roanne |
|
31/10/2009 |
CREARBORIS
485357735 -
S.A.R.L. à associé unique Capital : 8 000,00 EUR
|
Changement objet Changement de l'objet et de l'activité
Gérant : CHABRY Alexis
le Bourg 42370 Les Noës |
|
31/10/2009 |
1 TAHITI 2009
509836755 -
Société en nom collectif Capital : 114 803,00 EUR
|
Augmentation de capital Augmentation de capital
Gérant associé en nom : PACIFIQUE FINANCE PARTICIPATION-1 Associé en nom collectif : DB - 1, représenté par M DE BREBISSON Christophe Thierry Marie Associé en nom collectif : DEVOUCOUX Arnaud Philippe Joseph Associé en nom collectif : CROUE François Michel Jean Associé en nom collectif : MAYNARD Annie Associé en nom collectif : ARTAUD Alain Roger Associé en nom collectif : MENSIER Eric Alain Associé en nom collectif : ROTENBERG Maxime Associé en nom collectif : SIMON Patrick David Associé en nom collectif : MOUGENOT Gérard Robert Associé en nom collectif : FAURE Régis Associé en nom collectif : VALDIGUIE Marc Jacques Louis Marie Associé en nom collectif : FREY Marguerite Associé en nom collectif : BERNADIN Pierre François Claude Associé en nom collectif : ROMEU Virginie Caroline Associé en nom collectif : CANTENOT Christian Max André Associé en nom collectif : DE VERDELHAN DES MOLLES Marc François Associé en nom collectif : DUPOIZAT Arnauld Philippe Frédéric Associé en nom collectif : FAYARD Franck Nicolas Michel Associé en nom collectif : GOUT Christian Pierre Associé en nom collectif : ARLECCHINI Marie France Associé en nom collectif : PERRAULT André Associé en nom collectif : ROLAND Associé en nom collectif : RUSTHUL Arnaud Max Associé en nom collectif : RUSTHUL Jean Etienne Associé en nom collectif : TOLLON Christophe Jean Marie Hubert Associé en nom collectif : KILBY David Leslie
2 rue des Mariniers 42120 Le Coteau |
|
31/10/2009 |
1 BORA BORA 2009
509836672 -
Société en nom collectif Capital : 113 633,00 EUR
|
Augmentation de capital
Gérant associé en nom : PACIFIQUE FINANCE PARTICIPATION-1 Associé en nom collectif : DB - 1, représenté par M DE BREBISSON Christophe Thierry Marie Associé en nom collectif : DEVOUCOUX Arnaud Philippe Joseph Associé en nom collectif : CROUE François Michel Jean Associé en nom collectif : MAYNARD Annie Associé en nom collectif : ARTAUD Alain Roger Associé en nom collectif : MENSIER Eric Alain Associé en nom collectif : ROTENBERG Maxime Associé en nom collectif : SIMON Patrick David Associé en nom collectif : MOUGENOT Gérard Robert Associé en nom collectif : FAURE Régis Associé en nom collectif : VALDIGUIE Marc Jacques Louis Marie Associé en nom collectif : FREY Marguerite Associé en nom collectif : BERNADIN Pierre François Claude Associé en nom collectif : ROMEU Virginie Caroline Associé en nom collectif : CANTENOT Christian Max André Associé en nom collectif : DE VERDELHAN DES MOLLES Marc François Associé en nom collectif : DUPOIZAT Arnauld Philippe Frédéric Associé en nom collectif : FAYARD Franck Nicolas Michel Associé en nom collectif : GOUT Christian Pierre Associé en nom collectif : ARLECCHINI Marie France Associé en nom collectif : PERRAULT André Associé en nom collectif : ROLAND Associé en nom collectif : RUSTHUL Arnaud Max Associé en nom collectif : RUSTHUL Jean Etienne Associé en nom collectif : TOLLON Christophe Jean Marie Hubert Associé en nom collectif : KILBY David Leslie
2 rue des Mariniers 42120 Le Coteau |
|
|
31/10/2009 |
1 MOOREA 2009
509816765 -
Société en nom collectif Capital : 112 744,00 EUR
|
augmentation de capital Augmentation de capital
Gérant associé en nom : PACIFIQUE FINANCE PARTICIPATION-1 Associé en nom collectif : DB - 1, représenté par M DE BREBISSON Christophe Thierry Marie Associé en nom collectif : DEVOUCOUX Arnaud Philippe Joseph Associé en nom collectif : CROUE François Michel Jean Associé en nom collectif : MAYNARD Annie Associé en nom collectif : ARTAUD Alain Roger Associé en nom collectif : MENSIER Eric Alain Associé en nom collectif : ROTENBERG Maxime Associé en nom collectif : SIMON Patrick David Associé en nom collectif : MOUGENOT Gérard Robert Associé en nom collectif : FAURE Régis Associé en nom collectif : VALDIGUIE Marc Jacques Louis Marie Associé en nom collectif : FREY Marguerite Associé en nom collectif : BERNADIN Pierre François Claude Associé en nom collectif : ROMEU Virginie Caroline Associé en nom collectif : CANTENOT Christian Max André Associé en nom collectif : DE VERDELHAN DES MOLLES Marc François Associé en nom collectif : DUPOIZAT Arnauld Philippe Frédéric Associé en nom collectif : FAYARD Franck Nicolas Michel Associé en nom collectif : GOUT Christian Pierre Associé en nom collectif : ARLECCHINI Marie France Associé en nom collectif : PERRAULT André Associé en nom collectif : ROLAND Associé en nom collectif : RUSTHUL Arnaud Max Associé en nom collectif : RUSTHUL Jean Etienne Associé en nom collectif : TOLLON Christophe Jean Marie Hubert Associé en nom collectif : KILBY David Leslie
2 rue des Mariniers 42120 Le Coteau |
|
31/10/2009 |
1 HUAHINE 2009
509806865 -
Société en nom collectif Capital : 112 528,00 EUR
|
Augmentation de capital Augmentation de capital
Gérant associé en nom : PACIFIQUE FINANCE PARTICIPATION-1 Associé en nom collectif : DB - 1, représenté par M DE BREBISSON Christophe Thierry Marie Associé en nom collectif : DEVOUCOUX Arnaud Philippe Joseph Associé en nom collectif : CROUE François Michel Jean Associé en nom collectif : MAYNARD Annie Associé en nom collectif : ARTAUD Alain Roger Associé en nom collectif : MENSIER Eric Alain Associé en nom collectif : ROTENBERG Maxime Associé en nom collectif : SIMON Patrick David Associé en nom collectif : MOUGENOT Gérard Robert Associé en nom collectif : FAURE Régis Associé en nom collectif : VALDIGUIE Marc Jacques Louis Marie Associé en nom collectif : FREY Marguerite Associé en nom collectif : BERNADIN Pierre François Claude Associé en nom collectif : ROMEU Virginie Caroline Associé en nom collectif : CANTENOT Christian Max André Associé en nom collectif : DE VERDELHAN DES MOLLES Marc François Associé en nom collectif : DUPOIZAT Arnauld Philippe Frédéric Associé en nom collectif : FAYARD Franck Nicolas Michel Associé en nom collectif : GOUT Christian Pierre Associé en nom collectif : ARLECCHINI Marie France Associé en nom collectif : PERRAULT André Associé en nom collectif : RUSTHUL Arnaud Max Associé en nom collectif : RUSTHUL Jean Etienne Associé en nom collectif : TOLLON Christophe Jean Marie Hubert Associé en nom collectif : KILBY David Leslie Associé en nom collectif : ROLAND
2 rue des Mariniers 42120 Le Coteau |
|
31/10/2009 |
EASTCOM
510805633 -
Société à responsabilité limitée Capital : 6 000,00 EUR
|
Transfert du siège et établissement principal
Gérant : DUFOUR Jérémie
27 rue Langenieux 42300 Roanne C |
|
31/10/2009 |
R.C.L.
510942337 -
Société à responsabilité limitée Capital : 8 340,00 EUR
|
Augmentation de capital
Gérant : LEGER Ludovic Jean François Michel
280 avenue Charles de Gaulle 42153 Riorges |
|
31/10/2009 |
LPB CONSTRUCTION
511917486 -
S.A.R.L. à associé unique Capital : 2 000,00 EUR
|
Changement de nom commercial et transfert du siège et établissement principal
Gérant : ZINK Pierrick Edouard
lieu-dit la Côte Maréchal 42470 Neaux |
|
31/10/2009 |
RANE
513024091 -
Société en nom collectif Capital : 10 000,00 EUR
|
Nomination de co-gérants Nomination de co-gérants
Co-gérant associé en nom : P. M. DIS Co-gérant associé en nom : CAUDRELIER Aline Gisèle Co-gérant associé en nom : RECHATIN Céline Catherine Janyck Co-gérant associé en nom : DESNOS Christelle
rue de l'Artisanat 42300 Mably |
|
31/10/2009 |
AMBULANCE - GESTION ET DEVELOPPEMENT A.G.D.
513251454 -
Société à responsabilité limitée Capital : 6 000,00 EUR
|
Transfert siège Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement d'activité
Co-gérant : PARDON Loïc Co-gérant : BELLONI Alexandre Bruno Co-gérant : DESMURS Florian Co-gérant : GONDRAS Sébastien
18 ter avenue du Polygone 42300 Roanne |
|
31/10/2009 |
CONCEPT@PC
514125616 -
Société à responsabilité limitée Capital : 5 100,00 EUR
|
Mise en activité suite création
Gérant : MORILLA André Jean-François
rue de la Croix Sotton 42460 Coutouvre |
|
31/10/2009 |
GROUPE MADO
514158062 -
Société par actions simplifiée Capital : 1 290 000,00 EUR
|
L'établissement secondaire devient établissement principal
Président de la société : PACHA, représenté par M LEONETTI Bernard Marcel Directeur général : DOUILLET Caroline Marie Bernadette Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA Commissaire aux comptes suppléant : EPINAT Jean-Pierre
rn7 lieu-dit la Croix 42470 Neaux |
|
31/10/2009 |
DESLOIR Laurent, Bernard, André
508329075 -
Société en nom personnel
|
Transfert d'établissement principal avec création Changement d'activité
Personne infiniment responsable : DESLOIR Laurent, Bernard, André
7 rue Louis Charles Bréguet 42160 Andrézieux-Bouthéon |
|
|
31/10/2009 |
S.C.I. MARTIN
334667102 -
Société civile immobilière Capital : 2 286,74 EUR
|
Changement de gérant
Gérant : CALLET François Pierre Marie Associé : MARTIN Josiane Associé : CALLET François Pierre Marie
6 route de la Varizelle 42400 Saint-Chamond |
|
31/10/2009 |
SOGESER
323902288 -
Société civile Capital : 1 372,04 EUR
|
Cessation d'activité avec dissolution
Liquidateur amiable : SERTILLANGE André Barthélémy Noël
120 avenue Albert Raimond 42270 Saint-Priest-en-Jarez |
|
31/10/2009 |
SEDOS CONSEIL
391196706 -
Société d'exercice libéral de forme anonyme Capital : 168 000,00 EUR
|
Changement de dénomination sociale Nomination d'un directeur général délégué
Président du conseil d'administration : GOUGEON Anne Denise Jacqueline Directeur général : GOUGEON Anne Denise Jacqueline Directeur général délégué : ALLIROT Martine Jeanne Directeur général délégué : VILLE Willy Yves Gilbert Directeur général délégué : COCHERIL Arnaud Charles Guillaume Administrateur : COCHET Jean Pierre Paul Louis Administrateur : ALLIROT Martine Jeanne Administrateur : GOUGEON Anne Denise Jacqueline Commissaire aux comptes titulaire : FAURY Didier Commissaire aux comptes suppléant : CREUSAT Didier
145 rue de la Montat 5 A 9 allée du Pont de l'Ane 42000 Saint-Etienne |
|
31/10/2009 |
FERRIOL-MATRAT INVESTISSEMENTS
423501055 -
Société à responsabilité limitée Capital : 343 200,00 EUR
|
Augmentation de capital
Gérant : FERRIOL Jean Paul Camille
22 rue de la Croix de Mission Z.I. Croix de Mission 42100 Saint-Etienne |
|
31/10/2009 |
ARCURI
490916871 -
Société civile immobilière Capital : 3 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Co-gérant : ARCURI Giuseppe Calogero Co-gérant : ARCURI Michel Associé : ARCURI Giuseppe Calogero Associé : ARCURI Michel
16 rue Jean Sébastien Bach 42000 Saint-Etienne |
|
31/10/2009 |
DESCHAMPS ELECTRICITE
504822701 -
S.A.R.L. à associé unique Capital : 2 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : DESCHAMPS Jean Christophe
lieu-dit les Ombres 42660 Saint-Genest-Malifaux |
|
31/10/2009 |
EXPERTIZ SANTE
432643922 -
S.A.R.L. à associé unique Capital : 20 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : VERGNAUD Stéphane
9 rue Aristide Briand 42160 Andrézieux-Bouthéon |
|
31/10/2009 |
GILANNE
435275383 -
Société civile immobilière Capital : 2 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Co-gérant : CRESCI Gilles Co-gérant : CRESCI Anne Co-gérant : CRESCI Rolland Associé : CRESCI Gilles Associé : CRESCI Anne Associé : CRESCI Rolland
15 rue Jean Claude Verpilleux 42000 Saint-Etienne |
|
31/10/2009 |
PARM
453373342 -
Société à responsabilité limitée Capital : 2 000,00 EUR
|
Changement de gérant
Gérant : MARTIN Johanna
353 route de Bellegarde 42330 Cuzieu |
|
31/10/2009 |
COURAT ET ASSOCIES
392792354 -
Société par actions simplifiée Capital : 40 000,00 EUR
|
Nomination de directeur général
Président : COURAT Jean Noël Directeur général : POULARD Frédéric François Robert Directeur général : FONSALE Didier Alain Jean Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BOREL ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : FRESSE Jean Paul
30 boulevard de l'Hippodrome 42110 Feurs |
|
|
31/10/2009 |
FINANCIERE CPF
481202562 -
Société à responsabilité limitée Capital : 600 000,00 EUR
|
Nomination d'un co-gérant
Co-gérant : POULARD Frédéric François Robert Co-gérant : COURAT Jean Noël Co-gérant : FONSALE Didier Alain Jean
30 boulevard de l'Hippodrome 42110 Feurs |
|
31/10/2009 |
BECOFER RHONE-ALPES AUVERGNE
509761813 -
Société à responsabilité limitée Capital : 2 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : LENOIR Nicolas Raymond
26 rue de la République 42440 Noirétable |
|
31/10/2009 |
C.CHOCOLAT
509453973 -
Société en nom personnel
|
Changement d'activité
Personne infiniment responsable : HAZO Christiane, Andree
9 rue du Minage 44190 Clisson |
|
31/10/2009 |
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN)
314684960 -
S.A. d'économie mixte Capital : 600 000,00 EUR
|
Changement d'administrateur nomination de l'union départementale de la confédération syndicale des familles de loireatlantique représentée par M GASNIER Jean, en remplacement de l'association locale de la consommation du logement et du cadre de vie
Président du conseil d'administration : NANTES METROPOLE - communauté urbaine..., représenté par M LEMASLE Jean-Pierre Auguste Vice-président : RETIERE Jean-François Marie Vice-président : GOULLET DE RUGY François Henri Vice-président : HIERNARD Hugues Raymond André Directeur général : BOESWILLWALD Alain Jean-Pierre René Administrateur : CHAMBRE DE COMM. ET D'INDUSTRIE NANTES.., représenté par M MOREAU Philippe Administrateur : DURAND Camille Louis Administrateur : TRANSDEV - STE EUROPENNE POUR LE...*, représenté par M CHAPUT Francis Administrateur : MAHE Albert Marcel Auguste André Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAG, représenté par M PATAULT Didier Bernard Gérard Administrateur : UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECOVEC Commissaire aux comptes suppléant : LECLAIR Gilles
3 rue Bellier 44000 Nantes |
|
31/10/2009 |
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES CORMORANS
348198425 -
Société civile immobilière Capital : 15 244,90 EUR
|
Changement de gérant
Associé indéfiniment responsable : MAPI Gérant associé indéfiniment responsable : PAYRAUDEAU Marc Michel Daniel
104 rue de Leinster 44240 La Chapelle-sur-Erdre |
|
31/10/2009 |
L'ECLAIREUR
378792154 -
Société par actions simplifiée Capital : 305 000,00 EUR
|
Cessation d'activité avec dissolution
Président de la société : GAUNAND Francis Daniel Gilbert Commissaire aux comptes titulaire : LHOMMEAU Philippe Commissaire aux comptes suppléant : EXCO ATLANTIQUE
44 rue Aristide Briand 44110 Châteaubriant |
|
31/10/2009 |
LES 3 MOULINS
379273287 -
Société par actions simplifiée Capital : 130 000,00 EUR
|
Transformation en société par actions simplifiée
Président de la société : VINET Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : SNR CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : ANREP Gérard
la Brosse Ténaud 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu |
|
31/10/2009 |
SCI DE LARMINAT
383720794 -
Société civile Capital : 1 000,00 EUR
|
Réduction du capital Changement de composition des associés
Gérant : BONNEAU Alain Noël Aristide Associé indéfiniment responsable : BONNEAU Yannick Aristide René Marie Associé indéfiniment responsable : LBI FRANCE Associé indéfiniment responsable : BONNEAU Alexandre Marie
Port Jean la Buraudière 44470 Carquefou |
|
31/10/2009 |
DATALLIANCE
385176607 -
S.A.S. unipersonnelle Capital : 38 113,00 EUR
|
Transformation en société par actions simplifiée Changement de dénomination sociale changement de président dans une société par actions simplifié
Président de la société : SODIFRANCE Commissaire aux comptes titulaire : SOLIS - MARC DHERBEY & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BLANCHARD Bernard
4 rue du Chateau de l'Eraudière 44300 Nantes |
|
31/10/2009 |
SCI LE BOIS MARTINEAU
401246665 -
Société civile Capital : 762,25 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Associé indéfiniment responsable : GRENON Loïc Joseph Gérant associé indéfiniment responsable : GRANGER Nicole Marie
2 boulevard François Blancho 44200 Nantes |
|
|
31/10/2009 |
KdB ISOLATION
410948186 -
Société anonyme à conseil d'administration Capital : 66 096,00 EUR
|
Changement d'administrateur
Président du conseil d'administration et directeur général : ERAUD Benoît Laurent Administrateur : DELANOS Jean-Pierre Francis Administrateur : GROUPE INVEST, représenté par MME BALEY Frédérique Commissaire aux comptes titulaire : BOLLORE Claude Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : RSM SECOVEC Commissaire aux comptes suppléant : BLANCHE Anne
2 rue Fernand Pelloutier 44300 Nantes |
|
31/10/2009 |
AGENCE COMMERCIALE BOUYER JOUBERT
421782624 -
Société à responsabilité limitée Capital : 436 240,00 EUR
|
Changement de co-gérant
Gérant : BOUYER Nicolas Yves
431 rue Louis Lumière 44430 Le Loroux-Bottereau |
|
31/10/2009 |
AGENCE COMMERCIALE BOUYER JOUBERT
421782624 -
Société à responsabilité limitée Capital : 436 240,00 EUR
|
Changement de forme Changement de gérant Réduction du capital
Gérant : BOUYER Nicolas Yves
431 rue Louis Lumière 44430 Le Loroux-Bottereau |
|
31/10/2009 |
SARL 3 M SERVICES
437651011 -
S.A.R.L. à associé unique Capital : 40 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : VISONNEAU Pierre Louis Paul Serge
7 rue Bélouga Parc d'Activités du Chaffault 44340 Bouguenais |
|
31/10/2009 |
HM&3J
480223288 -
Société par actions simplifiée Capital : 8 506 205,00 EUR
|
Augmentation de capital
Président de la société : HAMON Fabrice Jean-Jacques Luc Directeur général : HAMON Jean-Philippe Yves Louis Commissaire aux comptes titulaire : BOMY Jean-Pierre Jack Joseph Commissaire aux comptes suppléant : FRADIN Françoise
42 rue du Onze Novembre 44110 Châteaubriant |
|
31/10/2009 |
NANTES EST AUTOS
492005343 -
Société à responsabilité limitée Capital : 10 000,00 EUR
|
Changement de gérant
Gérant : CAMUS Nicolas Georges Martin
1 rue des Luthiers 44700 Orvault |
|
31/10/2009 |
A. BANIEL CONSULTING
497916247 -
Société à responsabilité limitée Capital : 20 000,00 EUR
|
Changement de gérant
Gérant : BANIEL Claudie Marie Isabelle
14 rue de l'Orée du Bourg 44880 Sautron |
|
31/10/2009 |
SARL LAPODE
499868248 -
Société à responsabilité limitée Capital : 1 468 000,00 EUR
|
Réduction du capital
Co-gérant : LARCHE Grégoire Yves Gilles Co-gérant : PODGORSKI Jean-Pierre
rue de la Fontaine Grillée Zone Artisanale du Pâtis 44690 La Haie-Fouassière |
|
31/10/2009 |
VICTORY
484232475 -
Société par actions simplifiée Capital : 40 000,00 EUR
|
changement de président dans une société par actions simplifié Changement de commissaire aux comptes
Président de la société : DESVERONNIERES Philippe Pierre Commissaire aux comptes titulaire : ARNAUD Guy Commissaire aux comptes suppléant : ORAIN Philippe
8 rue du Pré Roux 44120 Vertou |
|
31/10/2009 |
F.T.G.C.
503047490 -
Société à responsabilité limitée Capital : 60 000,00 EUR
|
Augmentation de capital
Gérant : METENIER Pascal Olivier
1 rue Charles Lindbergh l'Aéropole 44340 Bouguenais |
|
31/10/2009 |
SIMELI
504252081 -
Société à responsabilité limitée Capital : 10 000,00 EUR
|
Démission d'un co-gérant Changement de gérant
Gérant : AUBRON Aurélie Marie Lucie Yvette
2 boulevard Amiral Courbet 44000 Nantes |
|