Date Société Description Liens
31/01/2011

SARL EMDACY

402562466 - Société par actions simplifiée
Capital : 7 500,00 EUR

Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.

Président : BERNON Jean Louis modification le 24 Janvier 2011

31/01/2011

CHATEAU PHELAN SEGUR SAS

333383933 - Société par actions simplifiée

Modification de représentant.

Président : GARDINIER Thierry Franck Georges modification le 05 Septembre 2006 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 24 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : EGO Pascal en fonction le 24 Janvier 2011

31/01/2011

SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE LA GIRONDE

468201132 - Société par actions simplifiée

Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : MACHENAUD FRANCOIS Commissaire aux comptes suppléant : HERMANN Jean Claude Président : HAUGUEL Bertrand en fonction le 24 Janvier 2011

31/01/2011

VILLA DES CRUS

479723033 - Société par actions simplifiée

Modification de représentant.

Président : BOUEY Patrick modification le 26 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : ALTUM en fonction le 24 Janvier 2011 Commissaire aux comptes : ALEXCAT en fonction le 24 Janvier 2011

31/01/2011

EARL LASSUS - LE REYSSE

528101470 - Exploitation agricole à responsabilité limitée

Mise en activité de la société. Modification de la date de début d'activité.



31/01/2011

S. C. I. SAMPAIO

383025624 - Société civile

Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.

Associé gérant : SAMPAIO José Carlos modification le 24 Janvier 2011 Associé gérant : DE OLIVEIRA SAMPAIO José Candido modification le 24 Janvier 2011

50 chemin du Nid de l'Agasse 33610 Cestas
31/01/2011

PRESTOM

347878944 - Société à responsabilité limitée à associé unique

Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination CHATEAU CASTERA Forme juridique SNC Siège social 33340 ST GERMAIN D ESTEUIL Rcs 338 832 173.



31/01/2011

SPITCOM AQUITAINE

505048801 - Société à responsabilité limitée

Modification de représentant.

Gérant : CISSE Ibrahima en fonction le 24 Janvier 2011

31/01/2011

SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES VERTES FEUILLES

429785603 - Société civile

Modification de l'adresse du siège. Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.



287 avenue de la Libération 33110 Le Bouscat
31/01/2011

COMPTOIR DES PRODUITS VANILLES ET DERIVES - C. P. V. D FOULON

788036655 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège.



1 rue Nully de Harcourt 33610 Canéjan
31/01/2011

TACOBAST

513742213 - Société à responsabilité limitée

Suppression du nom commercial. Cessation d'activité de la société à compter du 17 janvier 2011.



31/01/2011

SOCIGA B B J

407774686 - Société par actions simplifiée
Capital : 431 220,00 EUR

Modification du capital.



31/01/2011

SARL XAM

393587530 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège.



28 avenue du Colonel Pierre Bourgoin 33127 Martignas-sur-Jalle
31/01/2011

SADEM ELECTRO-MENAGER

424451433 - Société à responsabilité limitée
Capital : 27 000,00 EUR

Modification du capital. Modification de représentant.

Gérant : RAGOT Valérie en fonction le 24 Janvier 2011

31/01/2011

ORSECO

424188282 - Société civile

Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.

Associé gérant : COSTEDOAT Sebastien modification le 24 Janvier 2011 Associé : COSTEDOAT Pierre en fonction le 24 Janvier 2011 Associé : SAINT GERMAIN Jany en fonction le 24 Janvier 2011

18 rue Pascal Mothes 33000 Bordeaux
31/01/2011

MANUELA M.

523384956 - Société à responsabilité limitée
Capital : 119 500,00 EUR

Modification du capital.



31/01/2011

CHABELLARD CRESSEND DEL NIBBIO STABLO TOURNAN

332679299 - Société civile de moyens

Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de représentant.

Associé gérant : CHABELLARD Claude modification le 10 Avril 2009 Associé gérant : DEL NIBBIO Claude modification le 10 Avril 2009 Associé gérant : STABLO Marc modification le 10 Avril 2009 Associé gérant : CRESSEND Thomas en fonction le 10 Avril 2009 Associé gérant : TOURNAN Romain en fonction le 24 Janvier 2011

31/01/2011

SCI G C S

490081775 - Société civile

Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.

Associé gérant : GRACIA Dominique, Claude modification le 24 Janvier 2011

16 rue Fernand Philippart 33000 Bordeaux
31/01/2011

ETABLISSEMENTS DUPY

429742588 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège.



157 avenue de la Libération 33380 Biganos
31/01/2011

MEDI FRANCE EUROPE

490177649 - Société par actions simplifiée
Capital : 10 072 022,00 EUR

Modification du capital.



31/01/2011

EARL VIGNON REGIS

481178499 - Société civile

Modification de l'adresse du siège.



76 avenue de la République 33240 Salignac
31/01/2011

AUX DELIRES D'EPICURE

504875790 - Société à responsabilité limitée
Capital : 40 000,00 EUR

Modification du capital.



31/01/2011

COLIMAR

451790810 - Société à responsabilité limitée

Cessation d'activité et dissolution de la société.

Liquidateur : BENSEGHIR Kamal modification le 24 Janvier 2011

31/01/2011

PISCINES CREATIONS

400962395 - Société en nom personnel

transfert etablissement principal

Personne infiniment responsable : CHABRIER Joël, Alain

19 bis les Androns 33710 Lansac
31/01/2011

TECHNI FREINS

301920666 - Société par actions simplifiée
Capital : 385 000,00 EUR

Changement de commissaire aux comptes suppléant

Président de la société : BRUNO FANARA GESTION - B.F.G., représenté par M FANARA Bruno Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE C.C. RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : GRIZEL Frédéric

lotissement le Carré Lot N 4 Verdet Est 33500 Libourne
31/01/2011

MAGNE

344130562 - Société à responsabilité limitée
Capital : 20 000,00 EUR

changement de gérant

Gérant : MAGNE Nathalie Catherine

4 rue Thiers 33500 Libourne
31/01/2011

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MUSSET PERE ET FILS

331337378 - S.C.E.A.
Capital : 22 000,00 EUR

DEPART D'UN CO-GERANT

Gérant associé indéfiniment responsable : MUSSET Pierre Marie Associé indéfiniment responsable : MUSSET Bernadette Monique Isabelle Associé indéfiniment responsable : MUSSET Jeanne Marie

Chateau Saint Pey 33330 Saint-Pey-d'Armens
31/01/2011

CULTOR

398113068 - Société à responsabilité limitée
Capital : 2 763 753,00 EUR

AUGMENTATION DE CAPITAL ET NOMINATION D'UN CO GERANT

Co-gérant : AMAR David André Marie Co-gérant : AMAR Darryl Benjamin Kevin Marie

Chateau le Mayne 33220 Saint-Quentin-de-Caplong
31/01/2011

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE LA CHAPELLE

410000376 - Société civile immobilière
Capital : 1 524,49 EUR

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL ET CHANGEMENT DE GERANT

Gérant associé indéfiniment responsable : FRANCOIS Michel Associé indéfiniment responsable : GHERCA Christine

Chateau de Fargues 33230 Coutras
31/01/2011

KOUTCHOU

421132804 - Société anonyme à conseil d'administration
Capital : 103 104,00 EUR

Augmentation de capital

Président du conseil d'administration : ROCAILLEUX Michel Jacques Administrateur : ROCAILLEUX Michel Jacques Administrateur : RAYMOND Claudine Administrateur : RAYMOND James Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LALANDE FARBOS ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : TOUTON Benoit Directeur général délégué : RAYMOND Claudine

rue des Bouquets 33230 Coutras
31/01/2011

SOS QUENOTTES

306170002 - Société civile de moyens
Capital : 6 402,85 EUR

DEPART D'UN COGERANT

Co-gérant associé indéfiniment responsable : DE JAUREGUIBERRY Philippe Jean Charles Co-gérant associé indéfiniment responsable : MADERN Philippe Laurent Dominique

5 rue Tranchard 33350 Saint-Magne-de-Castillon
31/01/2011

SELARL THALES

448732214 - Société d'exercice libéral A.R.L.
Capital : 140 000,00 EUR

REDUCTION DU CAPITAL + DEPART D'UN CO GERANT

Co-gérant : WINTER Aymeric Co-gérant : FABAREZ Muriel Arietta

17 rue Henri Dunant 33230 Coutras
31/01/2011

LES CHAILLES

480223510 - S.C.E.A.
Capital : 2 000,00 EUR

DISSOLUTION

Associé indéfiniment responsable : BAILLARGUET Bruno Jean Associé indéfiniment responsable : BAILLARGUET Philippe Guy Liquidateur amiable : BAILLARGUET Philippe Guy

1 lieu-dit Montremblant 33330 Saint-Emilion
31/01/2011

WINEVEST SAINT-EMILION

483354023 - Société civile
Capital : 3 000 000,00 EUR

AUGMENTATION DE CAPITAL

Gérant associé indéfiniment responsable : WINEVEST PARTNERS I, représenté par SAS D M CONSULT

32 route de Saint Emilion 33570 Puisseguin
31/01/2011

COMPTOIR DES SPORTS

489816900 - Société à responsabilité limitée
Capital : 15 000,00 EUR

DEPART D'UN CO GERANT

Gérant : PERRIER Olivier Laurent

33 rue Alsace Lorraine 33220 Sainte-Foy-la-Grande
31/01/2011

NIALSTAR

453276883 - Société par actions simplifiée
Capital : 454 032,00 EUR

CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

Président de la société : PIERRON Annick Emilie Directeur général : ERMACORA Raoul Gilbert Commissaire aux comptes titulaire : FABRE NOUTARY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GOUL

32 route de Lussac 33910 Saint-Denis-de-Pile
31/01/2011

ALU CONCEPT

428141337 - Société à responsabilité limitée
Capital : 8 000,00 EUR

nomination d'un co gérant

Gérant : COUTEAU Jean Claude Joseph Co-gérant : SANCHEZ Isabelle

1 lieu-dit Laborie de Gariga 33420 Grézillac
31/01/2011

CALI

504520784 - Société à responsabilité limitée
Capital : 15 000,00 EUR

Changement de gérant

Gérant : MAYOU Marie France

51 rue Jules Ferry 33500 Libourne
31/01/2011

SCI PREMIUM IMMO

505132613 - Société civile immobilière
Capital : 150,00 EUR

Transfert du siège social

Gérant associé indéfiniment responsable : CASTERA Philippe Alain Associé indéfiniment responsable : CASTERA Ludovic Associé indéfiniment responsable : CASTERA Cyrille Philippe

29 rue Fonneuve 33500 Libourne
31/01/2011

DECOHOME

508614518 - Société à responsabilité limitée
Capital : 100,00 EUR

dissolution

Liquidateur amiable : de CONINCK Anne Ghislaine Marie

2 lieu-dit Bas Canon 33126 Saint-Michel-de-Fronsac
31/01/2011

BANTEGNIES ET FILS

417941861 - S.C.E.A.
Capital : 1 000,00 EUR

Changement de gérant

Gérant associé indéfiniment responsable : BANTEGNIES FINANCE Associé indéfiniment responsable : BANTEGNIES Frantz Jean Bernard Associé indéfiniment responsable : BANTEGNIES Eric Jean François

Chateau Bertinerie 33620 Cubnezais
31/01/2011

FORT

353141344 - S.A.S. unipersonnelle
Capital : 35 000,00 EUR

CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE

Président de la société : FORT Arnaud André Pierre

9 Z.A.C. du Pont de Cotet 33620 Saint-Mariens
31/01/2011

SARL CHATEAU CAP DE FAUGERES

518985379 - Société à responsabilité limitée
Capital : 3 875 000,00 EUR

augmentation de capital mise en activité

Gérant non associé : VON DER WEID Roger François

lieu-dit Faugère 33350 Sainte-Colombe
31/01/2011

GLR

523515252 - Société civile immobilière
Capital : 2 000,00 EUR

transfert du siege social

Gérant associé indéfiniment responsable : RIVIERE Guillaume Associé indéfiniment responsable : GRIZEL Frédéric Lionel Associé indéfiniment responsable : LAVIE Olivier

les Berges de l'Isle 189 avenue Foch BP 104 33501 Libourne Cedex
31/01/2011

LA TABLE DU BUFFET

524304946 - Société à responsabilité limitée
Capital : 5 000,00 EUR

Changement de gérant

Gérant : MECHAIN Marie

place du 8 Maï 1945 33230 Coutras
31/01/2011

SARL IDEM MENUISERIE

525224267 - Société à responsabilité limitée
Capital : 2 000,00 EUR

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL ET CHANGEMENT DE GERANT

Gérant : NAUD Valérie

26 rue de Fond Rouchain 33230 Saint-Médard-de-Guizières
31/01/2011

DARDIE Thierry

391172400 - Société en nom personnel

Transfert de l'établissement principal

Personne infiniment responsable : DARDIE Thierry

1 rue Emile Zola 34440 Nissan lez Ensérune
31/01/2011

RIEU Patricia

509999959 - Société en nom personnel

Etablissement principal donné en location-gérance

Personne infiniment responsable : RIEU Patricia

19 rue de la République 34600 Bédarieux
31/01/2011

LEFRANC Albert

484843313 - Société en nom personnel

Transfert de l'établissement principal

Personne infiniment responsable : LEFRANC Albert

12 rue de la République 34620 Puisserguier
31/01/2011

SURRIBAS Virginie

429015803 - Société en nom personnel

Modification survenue sur l'activité

Personne infiniment responsable : SURRIBAS Virginie

Archives
CELFI
CARRELAGES DU SUD
DES REVES
ALPHATEC SARL
ROGGERO CHANDRA
SYNDICAT COPROPRIETE RES MA CAMPAGNE