IMMATRICULATION
10/08/2011

Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS Commissaire aux comptes titulaire : DE BAILLIENCOURT Thierry Président : CGE DISTRIBUTION représenté par BOUVERESSE Laurent

DEPOTS DES COMPTES
30/09/2008 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

6-8 rue Ambroise Croizat 91120 Palaiseau
07/10/2009 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

6-8 rue Ambroise Croizat Zone Industrielle des Glaises 91120 Palaiseau
07/09/2010 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

6-8 rue Ambroise Croizat Zone Industrielle des Glaises 91120 Palaiseau
15/11/2011 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
25/10/2012 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
21/10/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
22/09/2014 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
30/07/2015 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
08/07/2016 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
01/08/2017 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
24/07/2018 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
13/08/2019 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
18/06/2021 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
18/08/2023 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
MODIFICATION
11/12/2008 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes suppléant : DROUARD Christophe. Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES. Président : CGE DISTRIBUTION représenté par BOUVERESSE Laurent modification le 28 Novembre 2008.

19/08/2009 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes suppléant : DROUARD Christophe Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS en fonction le 11 Août 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DE BAILLIENCOURT Thierry en fonction le 11 Août 2009

04/12/2011 Modification de la forme juridique. Modification du capital.

Capital : 2 732 000,00 EUR

05/04/2013 Modification du capital.

Capital : 3 080 000,00 EUR

23/06/2013 Modification de la dénomination.



30/07/2013 Modification du capital.

Capital : 1 982 750,00 EUR

01/12/2013 Modification du capital.

Capital : 2 662 550,00 EUR

22/07/2015 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 Président : CGE DISTRIBUTION représenté par BOUVERESSE Laurent en fonction le 02 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015

01/09/2017 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 ;
Président : CGE DISTRIBUTION modification le 29 Août 2017 ;
Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015

11/01/2018 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 ;
Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015 ;
Président : SONEPAR FRANCE en fonction le 09 Janvier 2018

18/07/2018 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 ;
Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015 ;
Président : PEDOUSSAUT Benoît en fonction le 13 Juillet 2018

27/01/2021 Modification survenue sur l'administration.

Président : ROSELLO Yves ;
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ;
Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
20/07/2021 Modification survenue sur l'administration.

Président : ROSELLO Yves ;
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
27/07/2021 Modification survenue sur l'administration.

Président : ROSELLO Yves ;
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
11/04/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Président : KHAÏDA Olivier ;
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
VENTE ET CESSION
22/01/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Cessions de la société au mardi 22 janvier 2013

Catégorie : Autre achat, apport, attribution

Description : AVIS DE PROJET DE FUSION AUTOMATISMES TECHNIQUES DISTRIBUTIONS Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 7622,45 EUR Siège social 22 R Maurice Caunes 31200 TOULOUSE N° RCS 390096311 RCS TOULOUSE, est société absorbée. COMPTOIR DE

Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.

30/09/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Cessions de la société au lundi 30 septembre 2013

Catégorie : Autre achat, apport, attribution

Description : AVIS DE PROJET DE FUSION LMV DISTRIBUTION Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 110010 EUR Siège social 6 R de la Retardais 35000 Rennes N° RCS 484350491 RCS RENNES, est société absorbée. CCF Forme juridique Société par actions

Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.

Voir la fiche Sirene de CCF Voir le rapport économique de CCF
ACCARIES JEAN-CLAUDE
AGENCE LUDIQUE
GAUBERVILLE CHRISTIAN
SCHWEIGERT MEYER BRIGITTE NOELLE
2N ASCENSEURS
NEUVLLE