IMMATRICULATION |
10/08/2011 |
Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS Commissaire aux comptes titulaire : DE BAILLIENCOURT Thierry Président : CGE DISTRIBUTION représenté par BOUVERESSE Laurent
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
30/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 rue Ambroise Croizat 91120 Palaiseau |
|
07/10/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 rue Ambroise Croizat Zone Industrielle des Glaises 91120 Palaiseau |
|
07/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÃVRY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 rue Ambroise Croizat Zone Industrielle des Glaises 91120 Palaiseau |
|
15/11/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
25/10/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
21/10/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
22/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
30/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
08/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
01/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
24/07/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
13/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
18/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
18/08/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
MODIFICATION |
11/12/2008 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : DROUARD Christophe. Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES. Président : CGE DISTRIBUTION représenté par BOUVERESSE Laurent modification le 28 Novembre 2008.
|
|
19/08/2009 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : DROUARD Christophe Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS en fonction le 11 Août 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DE BAILLIENCOURT Thierry en fonction le 11 Août 2009
|
|
04/12/2011 |
Modification de la forme juridique. Modification du capital.
Capital : 2 732 000,00 EUR
|
|
05/04/2013 |
Modification du capital.
Capital : 3 080 000,00 EUR
|
|
23/06/2013 |
Modification de la dénomination.
|
|
30/07/2013 |
Modification du capital.
Capital : 1 982 750,00 EUR
|
|
01/12/2013 |
Modification du capital.
Capital : 2 662 550,00 EUR
|
|
22/07/2015 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 Président : CGE DISTRIBUTION représenté par BOUVERESSE Laurent en fonction le 02 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015
|
|
01/09/2017 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 ; Président : CGE DISTRIBUTION modification le 29 Août 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015
|
|
11/01/2018 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015 ; Président : SONEPAR FRANCE en fonction le 09 Janvier 2018
|
|
18/07/2018 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015 ; Président : PEDOUSSAUT Benoît en fonction le 13 Juillet 2018
|
|
27/01/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : ROSELLO Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael
73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
20/07/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : ROSELLO Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
27/07/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : ROSELLO Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
11/04/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : KHAÃDA Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex |
|
VENTE ET CESSION |
22/01/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Cessions de la société au mardi 22 janvier 2013
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION AUTOMATISMES TECHNIQUES DISTRIBUTIONS Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 7622,45 EUR Siège social 22 R Maurice Caunes 31200 TOULOUSE N° RCS 390096311 RCS TOULOUSE, est société absorbée. COMPTOIR DE
Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
|
|
30/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Cessions de la société au lundi 30 septembre 2013
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION LMV DISTRIBUTION Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 110010 EUR Siège social 6 R de la Retardais 35000 Rennes N° RCS 484350491 RCS RENNES, est société absorbée. CCF Forme juridique Société par actions
Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
|
|