IMMATRICULATION
10/08/2011

Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS Commissaire aux comptes titulaire : DE BAILLIENCOURT Thierry Président : CGE DISTRIBUTION représenté par BOUVERESSE Laurent

DEPOTS DES COMPTES
30/09/2008 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

6-8 rue Ambroise Croizat 91120 Palaiseau
07/10/2009 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

6-8 rue Ambroise Croizat Zone Industrielle des Glaises 91120 Palaiseau
07/09/2010 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

6-8 rue Ambroise Croizat Zone Industrielle des Glaises 91120 Palaiseau
15/11/2011 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
25/10/2012 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
21/10/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
22/09/2014 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
30/07/2015 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
08/07/2016 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
01/08/2017 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
24/07/2018 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
13/08/2019 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 rue Noël Pons 92737 Nanterre Cedex
18/06/2021 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
18/08/2023 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
MODIFICATION
11/12/2008 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes suppléant : DROUARD Christophe. Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES. Président : CGE DISTRIBUTION représenté par BOUVERESSE Laurent modification le 28 Novembre 2008.

19/08/2009 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes suppléant : DROUARD Christophe Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS en fonction le 11 Août 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DE BAILLIENCOURT Thierry en fonction le 11 Août 2009

04/12/2011 Modification de la forme juridique. Modification du capital.

Capital : 2 732 000,00 EUR

05/04/2013 Modification du capital.

Capital : 3 080 000,00 EUR

23/06/2013 Modification de la dénomination.



30/07/2013 Modification du capital.

Capital : 1 982 750,00 EUR

01/12/2013 Modification du capital.

Capital : 2 662 550,00 EUR

22/07/2015 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 Président : CGE DISTRIBUTION représenté par BOUVERESSE Laurent en fonction le 02 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015

01/09/2017 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 ;
Président : CGE DISTRIBUTION modification le 29 Août 2017 ;
Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015

11/01/2018 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 ;
Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015 ;
Président : SONEPAR FRANCE en fonction le 09 Janvier 2018

18/07/2018 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 13 Juillet 2015 ;
Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael en fonction le 13 Juillet 2015 ;
Président : PEDOUSSAUT Benoît en fonction le 13 Juillet 2018

27/01/2021 Modification survenue sur l'administration.

Président : ROSELLO Yves ;
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ;
Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gael

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
20/07/2021 Modification survenue sur l'administration.

Président : ROSELLO Yves ;
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
27/07/2021 Modification survenue sur l'administration.

Président : ROSELLO Yves ;
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
11/04/2023 Modification survenue sur l\'administration.

Président : KHAÏDA Olivier ;
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A

73 Rue Noel Pons 92737 Nanterre Cedex
VENTE ET CESSION
22/01/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Cessions de la société au mardi 22 janvier 2013

Catégorie : Autre achat, apport, attribution

Description : AVIS DE PROJET DE FUSION AUTOMATISMES TECHNIQUES DISTRIBUTIONS Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 7622,45 EUR Siège social 22 R Maurice Caunes 31200 TOULOUSE N° RCS 390096311 RCS TOULOUSE, est société absorbée. COMPTOIR DE

Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.

30/09/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Cessions de la société au lundi 30 septembre 2013

Catégorie : Autre achat, apport, attribution

Description : AVIS DE PROJET DE FUSION LMV DISTRIBUTION Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 110010 EUR Siège social 6 R de la Retardais 35000 Rennes N° RCS 484350491 RCS RENNES, est société absorbée. CCF Forme juridique Société par actions

Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.

Voir la fiche Sirene de CCF Voir le rapport économique de CCF
BIESSY NICOLAS
MATHEWS BAESA DONNA
LE FAUBOURG
LE PERU DANIEL ANNE LAURE
SCI DES SOURCES
VANCAEYZEELE BRUNO MICHEL JACQUES