DEPOTS DES COMPTES
03/08/2008 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVINS

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum Saint-Michel 02500 Hirson
12/08/2009 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum Saint-Michel 02500 Hirson
28/06/2010 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
11/07/2011 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
07/05/2012 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
10/06/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
05/08/2014 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
28/07/2015 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
24/08/2016 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
29/06/2017 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
09/08/2018 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
02/08/2019 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
15/06/2021 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
03/07/2022 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
21/07/2023 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
MODIFICATION
28/02/2010 Changement de président de S.A.S.

Président de la société : HOFMANN Bernd Walter Directeur général : ROSER André Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS GUERARD Commissaire aux comptes suppléant : RENY Patrick

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
25/05/2010 Départ du directeur général

Président de la société : HOFMANN Bernd Walter Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS GUERARD Commissaire aux comptes suppléant : RENY Patrick

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
09/07/2010 Nomination d'un directeur général

Président de la société : HOFMANN Bernd Walter Directeur général : DEON Laurent Maurice Pierre Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS GUERARD Commissaire aux comptes suppléant : RENY Patrick

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
22/03/2013 modification survenue sur l'administration

modification du Président de la société Hofmann, Bernd Walter, nomination du Président de la société : Gerig, Moritz

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
09/10/2013 modification survenue sur l'administration

Directeur général partant : Deon, Laurent Maurice Pierre, nomination du Directeur général : Jonczyk, Bruno Jean

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
04/12/2014 modification survenue sur l'administration

Président partant : Gerig, Moritz, nomination du Président : Mewaldt, Frank

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
11/05/2016 modification survenue sur l'administration

Directeur général partant : Jonczyk, Bruno Jean, nomination du Directeur général : Viguier, nom d'usage : Jamgotchian, Sonia Michèle Andrée

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
07/12/2016 modification survenue sur l'administration

Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS GUERARD, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., modification du Commissaire aux comptes suppléant Reny, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
03/03/2017 modification survenue sur l'administration

Président partant : Mewaldt, Frank, modification du Président Viguier, nom d'usage : Jamgotchian, Sonia Michèle Andrée, nomination du Directeur général : Maine, Francis Michel Claude

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
17/08/2018 modification survenue sur l'administration

Président partant : Viguier, nom d'usage : Jamgotchian, Sonia Michèle Andrée ;
nomination du Président : Detais, Eric Marc

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
11/03/2020 modification survenue sur l'administration

modification du Président Maine, Francis Michel Claude ;
Président partant : Detais, Eric Marc

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
03/08/2021 modification survenue sur la dénomination



88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
11/05/2022 modification survenue sur l'administration

Président partant : Maine, Francis Michel Claude ;
nomination du Président : Canard, Jérôme Jean Joël

88 rue Léon Blum 02830 Saint-Michel
Voir la fiche Sirene de EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS Voir le rapport économique de EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS
LAURENT LYDIE
QUEUILLE DOMINIQUE LOUISE
COSSON JEAN-FRANCOIS
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS
MELYANDA
ZWANG GERARD