DEPOTS DES COMPTES
12/09/2008 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
24/08/2009 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
11/10/2010 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
12/09/2011 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
17/09/2012 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
29/08/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
06/09/2014 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
31/08/2015 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
23/08/2016 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
24/08/2017 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
21/08/2018 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
17/09/2019 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
01/09/2021 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 Rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
27/09/2022 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 Rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
21/05/2023 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

42 Rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
MODIFICATION
16/09/2009 Modification de représentant.

Président : SALINI PHILIPPE modification le 24 Août 2007 Directeur général : SALINI STEPHANE JEAN modification le 24 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : JOLY Olivier en fonction le 01 Août 2006 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE en fonction le 01 Août 2006 Directeur général délégué : GALLINELLI Mario en fonction le 07 Septembre 2009

27/05/2011 Modification de représentant.

Président : SALINI PHILIPPE modification le 24 Août 2007 Directeur général : SALINI STEPHANE JEAN modification le 24 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : JOLY Olivier en fonction le 01 Août 2006 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE en fonction le 01 Août 2006

07/02/2012 Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination D. M. S INGENIERIE Forme juridique SAS Siège social 1231 avenue du Mondial 34000 Montpellier Rcs Montpellier 339 583 882. Date d'effet: le 30/12/2011.

Capital : 408 000,00 EUR

26/09/2013 Modification de la dénomination. Modification du nom commercial.



21/02/2018 Modification de représentant.

Président : SALINI STEPHANE JEAN modification le 18 Février 2018 ;
Commissaire aux comptes suppléant : JOLY Olivier en fonction le 01 Août 2006 ;
Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE en fonction le 01 Août 2006

25/02/2022 Modification survenue sur l'activité.



42 Rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
24/06/2022 Modification survenue sur l'administration.

Président : SALINI STEPHANE JEAN ;
Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE

42 Rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
01/12/2022 Modification survenue sur l\'administration.

Président : TARDIGRADE ;
Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE

42 Rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
VENTE ET CESSION
29/11/2011 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Cessions de la société au mardi 29 novembre 2011

Catégorie : Autre achat, apport, attribution

Description : La société absorbante :SALINI ENTREPRISE Société par Actions Simplifiée au Capital de 200 000 euros Siège social : 42 rue du Commandant Rolland 93350 LE BOURGET 652 031 832 RCS BOBIGNY La société absorbée : D. M. S. INGENIERIE Société par Actions Sim

Opposition : Art L. 236-14 du code de commerce

Origine du fond : Avis de projet commun de fusion ou de scission nationale

Type d'établissement : Etablissement principal

42 rue du Commandant Rolland 93350 le Bourget
Voir la fiche Sirene de SALINI IMMOBILIER Voir le rapport économique de SALINI IMMOBILIER
CARRY RAYMOND HUBERT
FRANCHET IVAN
COMITE REG OLYMPIQUE SPORTIF POITOU CHAR
LYCEE PROFESSIONNEL RENEE BONNET
2LMK
PAIGNEAU FLORENCE