DEPOTS DES COMPTES
24/04/2008 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
03/04/2009 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
23/12/2009 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
27/12/2010 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
15/12/2011 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
21/08/2012 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
29/06/2013 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
07/06/2014 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
17/06/2015 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
08/07/2016 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
24/08/2017 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
31/07/2018 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
13/11/2019 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 rue Jean Nicot 93500 Pantin
22/08/2021 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 Rue Jean Nicot 93500 Pantin
12/08/2022 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 Rue Jean Nicot 93500 Pantin
25/06/2023 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels

5 Rue Jean Nicot 93500 Pantin
MODIFICATION
24/05/2009 Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : STE BLR ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES. Président : LEGRAND FRANCE représenté par SCHNEPP Gilles modification le 13 Mai 2009.

25/12/2011 Modification de représentant.

Président : LEGRAND FRANCE représenté par SCHNEPP Gilles modification le 13 Mai 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 16 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : HOLDING EXPERTISE CONSEIL en fonction le 16 Décembre 2011

22/06/2014 Modification de représentant.

Président : LEGRAND FRANCE modification le 13 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 16 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : HOLDING EXPERTISE CONSEIL en fonction le 16 Décembre 2011 Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : BARLET Bruno en fonction le 13 Juin 2014

16/12/2015 Modification de représentant.

Président : LEGRAND FRANCE modification le 13 Juin 2014 Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : BARLET Bruno en fonction le 13 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Décembre 2015

29/01/2016 Modification de représentant.

Président : LEGRAND FRANCE modification le 13 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Décembre 2015 Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : COQUART Benoît, Nicolas en fonction le 22 Janvier 2016

29/05/2018 Modification de représentant.

Président : LEGRAND FRANCE modification le 13 Juin 2014 ;
Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Décembre 2015 ;
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Décembre 2015 ;
Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : DESCAMPS David, Hervé, Gilles, Marie en fonction le 25 Mai 2018

12/10/2022 Modification survenue sur l\'administration.

Président : LEGRAND FRANCE ;
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ;
Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe

5 Rue Jean Nicot 93500 Pantin
Voir la fiche Sirene de CIE FRANCO EUROPEENNE D'ELECTRICITE Voir le rapport économique de CIE FRANCO EUROPEENNE D'ELECTRICITE
ESPOIR D'AFRIQUE
AU NORMANDY
SCI BIG APPLE CORE
ECOLE DE PARACHUTISME DE BESANCON F.C.
MUYL ISABELLE
COMMUNE DE SOMMAUTHE