PACKPROSPECT : Boostez votre prospection BtoB


149 €

Economisez jusqu'a 80% sur vos fichiers de prospection BtoB qualifiés

Fichiers qualifiés avec nom des dirigeants - Sources officielles PACKPROSPECT.COM


Présentation de M Pierre MARQUET Président de SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

M Pierre MARQUET


Président de SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

M Pierre MARQUET a 63 ans ( naissance en 1961), est Président de la société SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

M Pierre MARQUET peut être contacté au siège de la société SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS par courrier à l'adresse SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS HAMEAU DE FLOSAILLES 2745 ROUTE DU BUGEY 38300 ST SAVIN FRANCE, par téléphone au 0474928093

Présentation de : SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

La société SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS est principalement dirigée par M Pierre MARQUET qui en est Président.

Cette société a pour activité principale : Fabrication de chaux et plâtre ,fabricant de chaux, fabricant de plâtre
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2352Z (Fabrication de chaux et plâtre), les activités sont :

  • Fabrication de chaux et plâtre
  • la fabrication de chaux vive, de chaux éteinte et de chaux hydraulique
  • la fabrication de plâtre

Mais sont exclues les activités :
  • la fabrication d'ouvrages en plâtre (cf23.62Z et 23.69Z)


La société SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/01/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34914014500013.


Dirigeant(s) de SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS


L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS est de 68 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 78 ans.

Anciens dirigeants :
  • M Denis MARQUET, Administrateur (1952) du 02 novembre 2005 au 27 février 2007
  • M Jean-Francois BRETON, Administrateur (1948) du 17 mai 2005 au 15 mai 2013
  • M Jean-Francois BRETON, Président (1948) du 12 janvier 2013 au 15 mai 2013
  • M Maurice BOVAL, Administrateur (1958) du 04 novembre 2008 au 13 janvier 2017
  • M Pierre MARQUET, Administrateur (1961) du 19 janvier 2005 au 04 novembre 2008
  • M Pierre MARQUET, Président (1961) du 27 février 2007 au 04 novembre 2008
  • M Pierre MARQUET, Président (1961) du 25 juillet 2010 au 13 janvier 2017


Dirigeants personne morale:
  • CABINET ACL AUDIT SA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 janvier 2017
  • CABINET KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 janvier 2017
  • SOFEG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 janvier 2017

    Les modifications survenues dans l'administration de la société :

    • 22 août 2010 : MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET Pierre devient président. BOVAL Maurice nom d'usage : BOVAL Maurice n'est plus président. BOVAL Maurice nom d'usage : BOVAL Maurice devient administrateur. MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET Pierre n'est plus administrateur.)
    • 25 janvier 2013 : BRETON Jean-Francois nom d'usage : BRETON devient président. MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET n'est plus président. MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET n'est plus administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur, nouvelle identité : BRETON Jean-Francois nom d'usage : BRETON. CABINET FLUCHAIRE MONTOYA ET ASSOCIES SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE devient commissaire aux comptes titulaire.)
    • 29 mai 2013 : BRETON Jean-Francois nom d'usage : BRETON n'est plus président. ARQUILLIERE Michel André nom d'usage : ARQUILLIERE devient président. ARQUILLIERE Michel André nom d'usage : ARQUILLIERE devient administrateur. BRETON Jean-Francois nom d'usage : BRETON n'est plus administrateur.)
    • 15 octobre 2014 : MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET devient président. ARQUILLIERE Michel André nom d'usage : ARQUILLIERE n'est plus président.)
    • 20 janvier 2017 : MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET n'est plus président. DE SURVILLE Loïc Gaëtan Marie nom d'usage : DE SURVILLE devient président. DE SURVILLE Loïc Gaëtan Marie nom d'usage : DE SURVILLE devient administrateur. BOVAL Maurice nom d'usage : BOVAL n'est plus administrateur)
    • 17 novembre 2017 : BALTHAZARD Gabriel nom d'usage : BALTHAZARD n'est plus administrateur. MORIAME Richard Paul Louis nom d'usage : MORIAME devient administrateur)
    • 09 septembre 2018 : DE SURVILLE Loïc Gaëtan Marie nom d'usage : DE SURVILLE n'est plus président. MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET devient président. SA à conseil d'administration KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire)
    • 07 mars 2019 : CHANTECLAIR Jacques Charles Marie nom d'usage : CHANTECLAIR devient administrateur. DE SURVILLE Loïc Gaëtan Marie nom d'usage : DE SURVILLE n'est plus administrateur)
    • 25 juillet 2019 : SOFEG n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ROUX Philippe nom d'usage : ROUX devient commissaire aux comptes titulaire. MURAT Jacques nom d'usage : MURAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société d'exercice libéral par acti SAFIGEC devient commissaire aux comptes suppléant)
    • 07 octobre 2021 : PILLOIX Gilbert nom d'usage : PILLOIX n'est plus administrateur. PILLOIX Régis Bruno François nom d'usage : PILLOIX devient administrateur)
    • 08 septembre 2022 : ARQUILLIERE Michel André nom d'usage : ARQUILLIERE n'est plus administrateur. ARTRU Guillaume Dominique Marie nom d'usage : ARTRU devient administrateur)

    Coordonnées de M Pierre MARQUET

    M Pierre MARQUET
    2745 RTE DU BUGEY
    38300 SAINT SAVIN

    Téléphone : 0474928093
    Société
    SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

    Les mandats de M Pierre MARQUET

    SAINT HILAIRE INDUSTRIES
    Président du conseil d`administration

    2745 RTE DU BUGEY 38300 SAINT SAVIN

    SAINT HILAIRE INDUSTRIES
    Président du conseil d`administration

    24530 LA CHAPELLE FAUCHER

    SAINT HILAIRE INDUSTRIES
    Directeur général

    2745 RTE DU BUGEY 38300 SAINT SAVIN

    SAINT HILAIRE INDUSTRIES
    Directeur général

    24530 LA CHAPELLE FAUCHER

    SCM DES DRS ARLES ET MARCOMBES
    Gérant

    2 PL KLEBER 69006 LYON 6EME

    SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS
    Président

    2745 RTE DU BUGEY 38300 SAINT SAVIN

    SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS
    Président

    LD DUIN 38460 TREPT

    SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS
    Président

    2745 RTE DU BUGEY 38300 SAINT SAVIN

    SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS
    Président

    LD DUIN 38460 TREPT

    SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS
    Administrateur

    2745 RTE DU BUGEY 38300 SAINT SAVIN

    SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS
    Administrateur

    LD DUIN 38460 TREPT

    STRADIS SA
    Administrateur

    4 RUE MARCEL DASSAULT 56890 SAINT AVE

    ASSIS GENERALE INGENIERIE REALISATION
    Président

    90 RUE ERNEST HEMINGWAY 29200 BREST

    ASSIS GENERALE INGENIERIE REALISATION
    Président

    73 RUE DE SAINT MANDRIER SUR MER 83140 SIX FOURS LES PLAGES

    ASSIS GENERALE INGENIERIE REALISATION
    Président

    62 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX

    ASSIS GENERALE INGENIERIE REALISATION
    Président

    90 RUE ERNEST HEMINGWAY 29200 BREST

    ASSIS GENERALE INGENIERIE REALISATION
    Président

    62 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX

    ASSIS GENERALE INGENIERIE REALISATION
    Président

    229 FARLEDE 83500 LA SEYNE SUR MER

    CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS
    Président du conseil d`administration

    38460 SAINT HILAIRE DE BRENS

    CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS
    Président du conseil d`administration

    LD GRANDS COMMUNAUX 38460 TREPT

    CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS
    Président du conseil d`administration

    2745 RTE DU BUGEY 38300 SAINT SAVIN

    CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS
    Directeur général

    38460 SAINT HILAIRE DE BRENS

    CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS
    Directeur général

    LD GRANDS COMMUNAUX 38460 TREPT

    CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS
    Directeur général

    2745 RTE DU BUGEY 38300 SAINT SAVIN

    GERAUD MONTALEAU
    Administrateur

    MONTALEAU 24270 SAINT CYR LES CHAMPAGNES

    COGIL
    Président

    LES BRANCHETTES 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

    COGIL
    Président

    LES BRANCHETTES 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

    S.A.S.AGDE COUBLANC
    Président

    LE BOURG 71170 COUBLANC

    S.A.S.AGDE COUBLANC
    Président

    LE BOURG 71170 CHASSIGNY SOUS DUN

    S.A.S.AGDE COUBLANC
    Président

    ZI DES ETANGS 71170 CHAUFFAILLES

    MARQUIS SAS
    Administrateur

    123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY SUR SEINE

    SCM LES CORDIERS
    Co-gérant

    4 RLE DES CORDIERS 91400 ORSAY

    RHONE-ALPES AMENDEMENTS
    Gérant

    2745 RTE DU BUGEY 38300 SAINT SAVIN

    SOC LANSSADE ET PIQUEREZ
    Administrateur

    10 RUE ETIENNE MAREY 75020 PARIS 20

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    AV DU 1 MAI 40220 TARNOS

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    RUE ZAC DES PLAYES 83500 LA SEYNE SUR MER

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    RTE DEPARTEMENTALE 20 13127 VITROLLES

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    130 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    75 CRS EMILE ZOLA 69100 VILLEURBANNE

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    730 RUE RENE DESCARTES 13100 AIX EN PROVENCE

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    9 RUE ALAIN FOURNIER 31300 TOULOUSE

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    81 RUE DE SIAM 29200 BREST

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    37 RTE DE TARBES 64320 IDRON

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    13 IMP SERGE REGGIANI 44800 SAINT HERBLAIN

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    300 RUE P RIVOALLON 29200 BREST

    ATEXIS FRANCE
    Administrateur

    300 RUE P RIVOALLON 29200 BREST

    CHAUX DE SAINT HILAIRE
    Gérant

    2745 RTE DU BUGEY 38300 SAINT SAVIN

    COUBLANC STORES
    Gérant

    LD LE BOURG 71170 COUBLANC

    HPA
    Gérant

    40 AV ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

    SCI DU 9 THERMIDOR
    Gérant

    18 PAS DU CHEMIN DE FER 91400 ORSAY

    CONSEIL QUALITE FORM DEVELOP DURABLE
    Gérant

    AV FRANCOIS NARDI 83000 TOULON

    SCI LAURA
    Gérant

    7 AV ANDRE ROUSSIN 13016 MARSEILLE 16

    AURNIMA
    Président

    LES BRANCHETTES 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

    AURNIMA
    Président

    LES BRANCHETTES 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

    Etat juridique de : SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

    IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
    Nom ou raison sociale de l'entreprise SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS
    Entrepreneurs individuels SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS
    Identifiant de l'entreprise 349140145
    Numéro interne du siège 00013
    Adresse 2745 RTE DU BUGEY 38300 SAINT SAVIN
    CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE
    Origine de la création de l'établissement Création (pour tout type de déclaration)
    Année et mois de création de l'établissement dimanche 01 janvier 1989
    Tranche d'effectif salarié de l'établissement 0 salarié
    Effectif salarié de l'établissement à la centaine près 0
    CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
    Nature juridique de l'entreprise SAS, société par actions simplifiée
    Tranche d'effectif de l'entreprise 10 à 19 salariés
    Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près 10
    Catégorie d'entreprise Petite ou Moyenne Entreprise
    Année et mois de création de l'entreprise dimanche 01 janvier 1989
    Tranche de chiffre d'affaires De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
    Dernier CA connu (2015) 8 111 000,00
    Résultat net 450 000,00
    Activité
    Indice de monoactivité de l'entreprise Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale
    Modalité de l'activité principale de l'entreprise Activité simple
    Caractère productif de l'entreprise Productif
    Activité principale du siège 2352Z : Fabrication de chaux et plâtre
    Activité principale de l'entreprise 2352Z : Fabrication de chaux et plâtre
    Activité principale 2352Z
    Première activité 2352Z
    Deuxième activité 4673A
    Activité au siege
    Secteur industrie
    Catégorie Autres industrie
    Activite Fabrication de chaux et plâtre
    Synonyme fabricant de chaux, fabricant de plâtre
    Principal fabricant de chaux
    Voir la fiche Sirene de SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

    Données comptables de SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

    Actif au bilan
    Année 2015
    Actif immobilisé 4 958 000
    Immobilisation incorporelle 119 000
    Immobilisation corporelle 4 839 000
    Immobilisation financière 190
    Actif circulant net 2 947 000
    Stock 193 000
    Avance 0
    Créance 2 093 000
    Placement 662 000
    Total Actif 7 906 000


    Passif au bilan
    Capitaux propre 3 417 000
    Autres fonds 0
    Provision 1 211 000
    Dette 3 278 000
    Total Passif 7 906 000


    Compte de résultat
    Chiffre d'affaire 8 111 000
    Produit d'exploitation 8 581 000
    Charge d'exploitation 7 909 000
    Résultat d'exploitation 672 000
    Produit financier net 9 000
    Charge financière 25 000
    Résultat financier -16 000
    Résultat courrant 655 000
    Produit exceptionnel 50
    Charges exceptionnelles 4 000
    Résultat exceptionnel -4 000
    Résultat net 450 000

    Carte

    Greffe de SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

    SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS est du ressort du greffe de VIENNE dont les coordonnées postales sont 27/31 RUE DE BOURGOGNE BP 247 38217 VIENNE CEDEX
    Le greffe peut être appelé au 04 74 59 68 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr.
    Les greffiers sont : FAURE Denis

    Conventions collectives de SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

    Les conventions collectives applicables à SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS de part son activité de 2352Z (Fabrication de chaux et plâtre) sont :

      Timeline des événements et des actes de SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

      Modification 27 janvier 2008
      modification survenue sur l'administration à compter du 22/06/2007
      commissaire aux comptes suppléant partant : MOIROUX (Paul), nouveau commissaire aux comptes suppléant : MURAT (Jacques).
      Modification 21 octobre 2008
      modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 18/06/2008
      changement de président ; ancien président : MARQUET (Pierre) ; nouveau président : BOVAL (Maurice).
      Depot des comptes 29 novembre 2008
      Cloture du 2007-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 24 juillet 2009
      Cloture du 2008-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 22 août 2010
      Modification de l'administration.
      MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET Pierre devient président. BOVAL Maurice nom d'usage : BOVAL Maurice n'est plus président. BOVAL Maurice nom d'usage : BOVAL Maurice devient administrateur. MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET Pierre n'est plus administrateur.
      Depot des comptes 06 septembre 2010
      Cloture du 2009-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 09 septembre 2011
      Cloture du 2010-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 01 août 2012
      Cloture du 2011-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 25 janvier 2013
      Modification de l'administration.
      BRETON Jean-Francois nom d'usage : BRETON devient président. MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET n'est plus président. MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET n'est plus administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur, nouvelle identité : BRETON Jean-Francois nom d'usage : BRETON. CABINET FLUCHAIRE MONTOYA ET ASSOCIES SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE devient commissaire aux comptes titulaire.
      Modification 29 mai 2013
      Modification de l'administration.
      BRETON Jean-Francois nom d'usage : BRETON n'est plus président. ARQUILLIERE Michel André nom d'usage : ARQUILLIERE devient président. ARQUILLIERE Michel André nom d'usage : ARQUILLIERE devient administrateur. BRETON Jean-Francois nom d'usage : BRETON n'est plus administrateur.
      Depot des comptes 14 octobre 2013
      Cloture du 2012-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 30 juillet 2014
      Cloture du 2013-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 15 octobre 2014
      Modification de l'administration.
      MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET devient président. ARQUILLIERE Michel André nom d'usage : ARQUILLIERE n'est plus président.
      Depot des comptes 28 juillet 2015
      Cloture du 2014-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 22 août 2016
      Cloture du 2015-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 20 janvier 2017
      Modification de l'administration.
      MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET n'est plus président. DE SURVILLE Loïc Gaëtan Marie nom d'usage : DE SURVILLE devient président. DE SURVILLE Loïc Gaëtan Marie nom d'usage : DE SURVILLE devient administrateur. BOVAL Maurice nom d'usage : BOVAL n'est plus administrateur
      Depot des comptes 14 août 2017
      Cloture du 2016-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 17 novembre 2017
      Modification de l'administration.
      BALTHAZARD Gabriel nom d'usage : BALTHAZARD n'est plus administrateur. MORIAME Richard Paul Louis nom d'usage : MORIAME devient administrateur
      Depot des comptes 12 juillet 2018
      Cloture du 2017-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 09 septembre 2018
      Modification de l'administration.
      DE SURVILLE Loïc Gaëtan Marie nom d'usage : DE SURVILLE n'est plus président. MARQUET Pierre Maurice nom d'usage : MARQUET devient président. SA à conseil d'administration KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire
      Modification 07 mars 2019
      Modification de l'administration.
      CHANTECLAIR Jacques Charles Marie nom d'usage : CHANTECLAIR devient administrateur. DE SURVILLE Loïc Gaëtan Marie nom d'usage : DE SURVILLE n'est plus administrateur
      Depot des comptes 11 juillet 2019
      Cloture du 2018-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 25 juillet 2019
      Modification de l'administration.
      SOFEG n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ROUX Philippe nom d'usage : ROUX devient commissaire aux comptes titulaire. MURAT Jacques nom d'usage : MURAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société d'exercice libéral par acti SAFIGEC devient commissaire aux comptes suppléant
      Modification 07 octobre 2021
      Modification de l'administration.
      PILLOIX Gilbert nom d'usage : PILLOIX n'est plus administrateur. PILLOIX Régis Bruno François nom d'usage : PILLOIX devient administrateur
      Depot des comptes 15 juillet 2022
      Cloture du 2021-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 08 septembre 2022
      Modification de l'administration.
      ARQUILLIERE Michel André nom d'usage : ARQUILLIERE n'est plus administrateur. ARTRU Guillaume Dominique Marie nom d'usage : ARTRU devient administrateur
      Depot des comptes 06 juillet 2023
      Cloture du 2022-12-31
      Comptes annuels et rapports
      Voir les événements bodacc de SOC EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS

      BIOMAR
      REGIONS COULEURS
      VERDIER SYLVAIN
      ARIA PRODUCTIONS
      LA CHORALE LOG'A RYTHMES
      SCI DU FAUBOURG