PACKPROSPECT : Boostez votre prospection BtoB


149 €

Economisez jusqu'a 80% sur vos fichiers de prospection BtoB qualifiés

Fichiers qualifiés avec nom des dirigeants - Sources officielles PACKPROSPECT.COM


Présentation de M Edward ARKWRIGHT Administrateur de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

M Edward ARKWRIGHT


Administrateur de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

M Edward ARKWRIGHT a 50 ans ( naissance en 1974), est Administrateur de la société SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

M Edward ARKWRIGHT peut être contacté au siège de la société SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES par courrier à l'adresse SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES 15 AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0149525050 ou par fax au 01 49 52 07 41

Présentation de : SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

La société SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES est principalement dirigée par M Edward ARKWRIGHT qui en est Administrateur.

Cette société a pour activité principale : Gestion de salles de spectacles ,salle de spectacles, salle de concerts, salle de théâtre, salle de danse, salle de music hall, cirques, chapiteaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9004Z (Gestion de salles de spectacles), les activités sont :

  • Gestion de salles de spectacles
  • l'exploitation de lieux ou salles de spectacle aménagés pour des représentations publiques : salles de concert, de théatre, de danse, de music hall, cirques, etc.

Mais sont exclues les activités :
  • l'exploitation de cinémas (cf59.14Z)
  • les activités des agences de vente de billets (cf79.90Z)
  • la gestion des musées de toute nature (cf91.02Z)


La société SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/04/1959 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 59202831000015.


Dirigeant(s) de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES


L'âge moyen des 15 dirigeants de la société SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES est de 67 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 84 ans.

Anciens dirigeants :
  • M Alain DESTREM, Administrateur (1945) du 17 mai 2005 au 30 mars 2017
  • M Andre LARQUIE, Administrateur (1938) du 19 janvier 2005 au 11 juin 2013
  • M Andre LARQUIE, Administrateur (1938) du 28 novembre 2009 au 09 janvier 2010
  • M Christian THOMAS DE PANGE, Administrateur (1958) du 12 septembre 2006 au 11 juin 2013
  • M Dessouffiana KEITA, Administrateur (1957) du 11 juin 2013 au 03 février 2016
  • M Dominique MEYER, Directeur général non administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 15 janvier 2011
  • M Edward ARKWRIGHT, Administrateur (1974) du 28 novembre 2009 au 11 juin 2013
  • M Francis LACLOCHE, Administrateur (1945) du 19 janvier 2005 au 12 septembre 2006
  • M Francis LEPIGEON, Directeur général délégué (1949) du 19 janvier 2005 au 30 mars 2017
  • M Francois DESNOYERS, Administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 17 mai 2005
  • M Jacques TADDEI, Administrateur (1946) du 17 mai 2005 au 12 septembre 2006
  • M Jean MENANTEAU, Administrateur (1964) du 19 janvier 2005 au 17 mai 2005
  • M Jean-Luc HEES, Administrateur (1951) du 11 juin 2013 au 07 juillet 2015
  • M Jean-Pierre LE PAVEC, Administrateur (1947) du 17 mars 2012 au 07 juillet 2015
  • M Jean-Pierre ROUSSEAU, Administrateur (1955) du 07 juillet 2015 au 03 février 2016
  • M Klaus JACOBS, Administrateur (1934) du 12 septembre 2006 au 07 juillet 2015
  • M Marc MORET, Administrateur (1942) du 19 janvier 2005 au 17 mai 2005
  • M Marc-Olivier DUPIN, Administrateur (1954) du 28 novembre 2009 au 17 mars 2012
  • M Mathieu GALLET, Administrateur (1977) du 07 juillet 2015 au 03 février 2016
  • M Olivier MOREL-MAROGER, Administrateur (1962) du 03 juillet 2010 au 07 juillet 2015
  • M Raymond SOUBIE, Président du conseil d`administration (1940) du 28 novembre 2009 au 09 janvier 2010
  • M Rene KOERING, Administrateur (1940) du 19 janvier 2005 au 17 mai 2005
  • M Thierry BEAUVERT, Administrateur (1956) du 17 mai 2005 au 03 juillet 2010
  • MME Christine DAVIDDI, Administrateur (1946) du 17 mai 2005 au 28 novembre 2009
  • MME Francoise DELASALLES, Administrateur (1962) du 12 septembre 2006 au 28 novembre 2009
  • MME Marie-Jose BLUTEAU, Administrateur (1944) du 19 janvier 2005 au 12 septembre 2006
  • MME Marie-Pierre DE SURVILLE, Administrateur (1965) du 07 juillet 2015 au 30 mars 2017


Dirigeants personne morale:
  • CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Administrateur depuis le 17 mai 2005
  • GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 juillet 2015
  • INSTITUT DE GESTION ET D`EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 juillet 2015
  • SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, Administrateur depuis le 03 février 2016
  • SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, Administrateur du 09 janvier 2010 au 11 juin 2013
  • SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, Administrateur du 11 juin 2013 au 03 février 2016
  • SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE SA, Administrateur du 28 novembre 2009 au 09 janvier 2010
  • STE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE SA, Administrateur du 17 mai 2005 au 28 novembre 2009

Coordonnées de M Edward ARKWRIGHT

M Edward ARKWRIGHT
15 AV MONTAIGNE
75008 PARIS 8

Téléphone : 0149525050
Société
SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

Les mandats de M Edward ARKWRIGHT

SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES
Administrateur

15 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8

CDC INTERNATIONAL CAPITAL
Administrateur

56 RUE DE LILLE 75007 PARIS 7

CDC INTERNATIONAL CAPITAL
Administrateur

67 RUE DE LILLE 75007 PARIS 7

ICADE
Administrateur

31 RUE DE LA GARE 93300 AUBERVILLIERS

ICADE
Administrateur

55 BD FELIX FAURE 93300 AUBERVILLIERS

ICADE
Administrateur

11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS 19

ICADE
Administrateur

27 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY LES MOULINEAUX

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

15 RUE DE BELGRADE 38000 GRENOBLE

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

8 PL DE LA REPUBLIQUE 26000 VALENCE

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

27 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS ALFORT

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

16 BD MONT D EST 93160 NOISY LE GRAND

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

3 RUE DE BERNE 67300 SCHILTIGHEIM

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

20 PL SAINT MARC 76000 ROUEN

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

7 RUE GENERAL CAMPI 20000 AJACCIO

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

70 AV LOUIS SALLENAVE 64000 PAU

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

1 PL RAVEZIES 33300 BORDEAUX

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

222 PL ERNEST GRANIER 34000 MONTPELLIER

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

RUE ALAIN SAVARY 25000 BESANCON

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

1 LA GRANDE ARCHE PAROI NORD 92800 PUTEAUX

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

7 RUE COLUMBIA 87280 LIMOGES

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

9 RUE GASTON BOYER 51100 REIMS

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

186 AV THIERS 69006 LYON 6EME

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

32 RUE DU BOEUF ST PATERNE 45000 ORLEANS

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

13 RUE JEAN GIONO 21000 DIJON

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

616 RUE MARIE CURIE 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

1 RUE JEANNE D ARC 66000 PERPIGNAN

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

24 AV GEORGES POMPIDOU 31130 BALMA

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

39 BD DEMORIEUX 72100 LE MANS

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 22190 PLERIN

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

PL DE BRETAGNE 35000 RENNES

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

455 PRO DES ANGLAIS 06000 NICE

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

70 RUE JEAN JAURES 86000 POITIERS

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

11 PL ST MARTIN 57000 METZ

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

2 AV GRUNER 42000 SAINT ETIENNE

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

9 RUE PIERRE CHALNOT 54000 NANCY

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

24 AV FRANCOIS FAVRE 74000 ANNECY

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

32 BD CARNOT 59800 LILLE

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

QUAI DE LA DOUANE 29200 BREST

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

4 RUE GAMBETTA 37000 TOURS

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

RUE GENERAL DE GAULLE 10000 TROYES

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

2 RUE LT DE VAISSEAU BOURELY 56100 LORIENT

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

30 RUE JEAN CLARET 63000 CLERMONT FERRAND

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

9 AV ALSACE LORRAINE 01000 BOURG EN BRESSE

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

26 BD SAINT ROCH 84000 AVIGNON

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

32 AV ALBERT EINSTEIN 17000 LA ROCHELLE

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

91 RUE JACQUES YVES COUSTEAU 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

24 RUE DROUOT 75009 PARIS 9

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

6 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

5 ALL MARCEL LECLERC 13008 MARSEILLE 8

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

RUE IRENE JOLIOT CURIE 60610 LACROIX SAINT OUEN

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

55 CHS DE LA MADELEINE 44000 NANTES

BPIFRANCE FINANCEMENT
Administrateur

10 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE 80440 BOVES

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

30 RUE HENRI GADEAU DE KERVILLE 76100 ROUEN

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

57 RUE DE BAYARD 31000 TOULOUSE

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

101 ALL DE DELOS 34000 MONTPELLIER

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

2 AV CARNOT 44000 NANTES

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

2 AV DE PARIS 45000 ORLEANS

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

78 RUE DE LA VILLETTE 69003 LYON 3EME

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

2 RUE ADOLPHE SEYBOTH 67000 STRASBOURG

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

12 RUE DU DOCTEUR HERPIN 37000 TOURS

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

11 PRV DE ROTTERDAM 59777 LILLE

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

ALL DE LA PASSE PIERRE 13800 ISTRES

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

41 AV FRANCOISE GIROUD 21000 DIJON

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

455 PRO DES ANGLAIS 06000 NICE

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

74 RUE GEORGES BONNAC 33000 BORDEAUX

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

52 RUE JACQUES HILLAIRET 75012 PARIS 12

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

67 AV DU PRADO 13006 MARSEILLE 6

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

267 AV DE VERDUN 83300 DRAGUIGNAN

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

1 AV DU PAYS DE CAEN 14460 COLOMBELLES

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

245 CRS AIME CESAIRE 29200 BREST

SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Président du conseil d`administration

1 PAS JOSEPH DELFRAISE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Etat juridique de : SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Nom ou raison sociale de l'entreprise SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES
Entrepreneurs individuels SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES
Identifiant de l'entreprise 592028310
Numéro interne du siège 00015
Adresse 15 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE
Origine de la création de l'établissement Sans objet
Année et mois de création de l'établissement jeudi 01 janvier 1959
Tranche d'effectif salarié de l'établissement 100 à 199 salariés
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près 100
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Tranche d'effectif de l'entreprise 100 à 199 salariés
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près 100
Catégorie d'entreprise Grande Entreprise
Année et mois de création de l'entreprise jeudi 01 janvier 1959
Tranche de chiffre d'affaires De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Dernier CA connu (2013 ) 9 661 000,00
Résultat net 17 000,00
Activité
Indice de monoactivité de l'entreprise Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale
Modalité de l'activité principale de l'entreprise Activité simple
Caractère productif de l'entreprise Productif
Activité principale du siège 9004Z : Gestion de salles de spectacles
Activité principale de l'entreprise 9004Z : Gestion de salles de spectacles
Activité principale 9004Z
Première activité 9004Z
Deuxième activité 9002Z
Troisième activité 9001Z
Quatrième activité 5630Z
Activité au siege
Secteur loisirs
Catégorie Culture
Activite Gestion de salles de spectacles
Synonyme salle de spectacles, salle de concerts, salle de théâtre, salle de danse, salle de music hall, cirques, chapiteaux
Principal salle de spectacles
Voir la fiche Sirene de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

Données comptables de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

Actif au bilan
Année 2013
Actif immobilisé 2 042 000
Immobilisation incorporelle 432 000
Immobilisation corporelle 1 205 000
Immobilisation financière 404 000
Actif circulant net 7 863 000
Stock 7 000
Avance 0
Créance 3 055 000
Placement 4 802 000
Total Actif 9 904 000


Passif au bilan
Capitaux propre 2 531 000
Autres fonds 0
Provision 17 000
Dette 7 356 000
Total Passif 9 904 000


Compte de résultat
Chiffre d'affaire 9 661 000
Produit d'exploitation 21 235 000
Charge d'exploitation 21 133 000
Résultat d'exploitation 102 000
Produit financier net 710
Charge financière 0
Résultat financier 710
Résultat courrant 102 000
Produit exceptionnel 0
Charges exceptionnelles 86 000
Résultat exceptionnel -86 000
Résultat net 17 000

Carte

Etablissements de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

Greffe de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné

Conventions collectives de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

Les conventions collectives applicables à SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES de part son activité de 9004Z (Gestion de salles de spectacles) sont :

    Timeline des événements et des actes de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

    Depot des comptes 24 avril 2008
    Cloture du 2007-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Modification 31 mai 2008
    modification survenue sur l'administration
    nomination de l'Administrateur : Marcel, Dominique
    Depot des comptes 29 mai 2009
    Cloture du 2008-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Modification 11 décembre 2009
    modification survenue sur l'administration
    Administrateur partant : Daviddi, Christine, Administrateur partant : Mercadal, nom d'usage : Delasalles, Françoise, nomination de l'Administrateur : Arkwright, Edward, nomination de l'Administrateur : Dupin, Marc-Olivier, Commissaire aux comptes suppléant partant : Perret, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lacaille, Xavier
    Depot des comptes 17 mai 2010
    Cloture du 2009-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Modification 18 juillet 2010
    modification survenue sur l'administration
    Administrateur partant : Beauvert, Thierry, nomination de l'Administrateur : Morel-Maroger, Olivier
    Modification 23 janvier 2011
    modification survenue sur l'administration
    nomination de l'Administrateur : Colombani, Jean-Marie
    Modification 23 janvier 2011
    modification survenue sur l'administration
    Directeur général non Administrateur partant : Meyer, Dominique, nomination du Directeur général non Administrateur : Franck, Michel
    Depot des comptes 18 avril 2011
    Cloture du 2010-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Modification 31 mars 2012
    modification survenue sur l'administration
    Administrateur partant : Dupin, Marc-Olivier, nomination de l'Administrateur : Le Pavec, Jean-Pierre, Commissaire aux comptes titulaire partant : Tetard, Gabriel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant partant : Lacaille, Xavier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
    Depot des comptes 16 avril 2012
    Cloture du 2011-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Depot des comptes 27 mai 2013
    Cloture du 2012-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Modification 23 juin 2013
    modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    modification de l'Administrateur SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE représenté par , Sueur Catherine Adresse : 5 rue des Filles Du Calvaire 75003 Paris, Administrateur partant : Larquie, Andre, Administrateur partant : Thomas De Pange, Christian, Administrateur partant : Arkwright, Edward, nomination de l'Administrateur : Hées, Jean-Luc, nomination de l'Administrateur : Keïta, Dessouffiana Fodé Lamine René Stéphane Kara, nomination de l'Administrateur : Bachy, François, nomination de l'Administrateur : Quatrehomme, Sophie
    Depot des comptes 27 juin 2014
    Cloture du 2013-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Modification 21 juillet 2015
    modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
    Administrateur partant : Jacobs, Klaus, Administrateur partant : Morel-Maroger, Olivier, Administrateur partant : Le Pavec, Jean-Pierre, Administrateur partant : Hées, Jean-Luc, nomination de l'Administrateur : Meyer, Dominique, nomination de l'Administrateur : Gallet, Mathieu, nomination de l'Administrateur : Maubouche, nom d'usage : de Surville, Marie-Pierre, nomination de l'Administrateur : Rousseau, Jean-Pierre
    Modification 12 février 2016
    modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    modification de l'Administrateur SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE représenté par , Gallet Mathieu Adresse : 24 quai du Louvre 75001 Paris, Administrateur partant : Keïta, Dessouffiana Fodé Lamine René Stéphane Kara, Administrateur partant : Gallet, Mathieu, Administrateur partant : Rousseau, Jean-Pierre, nomination de l'Administrateur : Ravache, Bérénice, nomination de l'Administrateur : Minczeles, Alain, nomination de l'Administrateur : Voinchet, Marc
    Depot des comptes 21 avril 2016
    Cloture du 2015-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Modification 16 avril 2017
    modification survenue sur l'administration
    Directeur général délégué partant : Lepigeon, Francis
    Depot des comptes 17 avril 2018
    Cloture du 2016-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Depot des comptes 17 avril 2018
    Cloture du 2017-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Modification 24 avril 2018
    modification survenue sur l'administration
    nomination de l'Administrateur : Petitjean, nom d'usage : Veil, Sibyle
    Depot des comptes 24 mars 2019
    Cloture du 2018-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Depot des comptes 14 avril 2021
    Cloture du 2020-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Depot des comptes 05 avril 2022
    Cloture du 2021-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Modification 13 avril 2022
    modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    modification de l'Administrateur CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par , Quatrehomme Sophie Adresse : 42 rue Henri Barbusse 75005 Paris ; Administrateur partant : Quatrehomme, Sophie
    Modification 01 février 2023
    modification survenue sur l\'administration
    Administrateur partant : Gall, Hugues ; Administrateur partant : Martin, Stéphane ; Administrateur partant : Senequier, Dominique ; Administrateur partant : Marcel, Dominique ; Administrateur partant : Colombani, Jean-Marie ; Administrateur partant : Weber, nom d\'usage : Demaria, Françoise Agnès
    Depot des comptes 26 mai 2023
    Cloture du 2022-08-31
    Comptes annuels et rapports
    Voir les événements bodacc de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES

    DEPOISIER MICHEL MARIE JOSEPH
    GRASTILLEUR MARIE FRANCE
    MARTINETTI DOMINIQUE MARIE
    SARL HENAND
    GLS 24
    HAOUMAL REDOUANE