PACKPROSPECT : Boostez votre prospection BtoB


149 €

Economisez jusqu'a 80% sur vos fichiers de prospection BtoB qualifiés

Fichiers qualifiés avec nom des dirigeants - Sources officielles PACKPROSPECT.COM


Présentation de MME Michele CHAMON Administrateur de LIBAULT

MME Michele CHAMON


Administrateur de LIBAULT

MME Michele CHAMON a 71 ans ( naissance en 1951), elle est Administrateur de la société LIBAULT

MME Michele CHAMON peut être contacté au siège de la société LIBAULT par courrier à l'adresse LIBAULT 28 RUE DE LA ROTONDE 58000 NEVERS FRANCE, par téléphone au 0386571067 ou par fax au 03 86 21 44 65

Présentation de : LIBAULT

La société LIBAULT est principalement dirigée par MME Michele CHAMON qui en est Administrateur.

Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux ,plombier, installateur de gaz
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4322A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :

  • Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
  • l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
  • réseaux de distribution d'eau et de gaz
  • plomberie et appareils sanitaires
  • installations d'extinction automatique d'incendie
  • l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
  • l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
  • l'installation de conduits

Mais sont exclues les activités :
  • le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)


La société LIBAULT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/04/1971 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 71188022900028.


Dirigeant(s) de LIBAULT



Anciens dirigeants :
  • M Pierre CHAMON, Directeur général délégué (1948) du 19 janvier 2005 au 29 avril 2017
  • M Pierre CHAMON, Administrateur (1948) du 19 février 2011 au 29 avril 2017
  • MME Michele CHAMON, Administrateur (1951) du 19 janvier 2005 au 29 avril 2017
  • MME Michele CHAMON, Administrateur (1951) du 28 septembre 2009 au 19 février 2011
  • MME Michele CHAMON, Directeur général (1951) du 30 octobre 2013 au 29 avril 2017
  • MME Sarah CHAMON, Administrateur (1977) du 28 septembre 2009 au 29 avril 2017


Dirigeants personne morale:

      Coordonnées de MME Michele CHAMON

      MME Michele CHAMON
      28 RUE DE LA ROTONDE
      58000 NEVERS

      Téléphone : 0386571067
      Société
      LIBAULT

      Les mandats de MME Michele CHAMON

      EARL DE LA TRANQUILLITE
      Gérant

      LE BAS ASTILLE 53220 SAINT ELLIER DU MAINE

      MATERIAUX SIMC
      Président

      SAINT JOSEPH 04100 MANOSQUE

      MATERIAUX SIMC
      Président

      QUAI LES BOUILLOTES 04700 ORAISON

      MATERIAUX SIMC
      Président

      PUYRICARD 13540 AIX EN PROVENCE

      MATERIAUX SIMC
      Président

      141 AV DU GENERAL LECLERC 13880 VELAUX

      MATERIAUX SIMC
      Président

      QUAI DE MOUGNE 84390 SAULT

      MATERIAUX SIMC
      Président

      QUA NAPOLLON 13400 AUBAGNE

      MATERIAUX SIMC
      Président

      LA TAPY 84170 MONTEUX

      MATERIAUX SIMC
      Président

      AV DES ENTREPRENEURS 83560 VINON SUR VERDON

      MATERIAUX SIMC
      Président

      LES MEILLERES 84160 CADENET

      MATERIAUX SIMC
      Président

      CHE DES ESCAMPADES 84170 MONTEUX

      MATERIAUX SIMC
      Président

      QUARTIER SUR CRAPONNE 13113 LAMANON

      MATERIAUX SIMC
      Président

      LES MIANS 84260 SARRIANS

      MATERIAUX SIMC
      Président

      370 CHE DES PLAINES 06370 MOUANS SARTOUX

      MATERIAUX SIMC
      Président

      1277 RTE D AIX EN PROVENCE 84120 PERTUIS

      MATERIAUX SIMC
      Président

      AV DU TUBE 13800 ISTRES

      MATERIAUX SIMC
      Président

      AV DE DRAGUIGNAN 83130 LA GARDE

      MATERIAUX SIMC
      Président

      ZI QUATRIEME AVENUE 13127 VITROLLES

      MATERIAUX SIMC
      Président

      115 CHE VICINAL DE LA MILLIERE ST MENET 13011 MARSEILLE 11

      MATERIAUX SIMC
      Président

      QUARTIER CHAPUS 13590 MEYREUIL

      MATERIAUX SIMC
      Président

      QUA LES COLONNES 04500 RIEZ

      MATERIAUX SIMC
      Président

      ZONE ARTISANALE 04130 VOLX

      MATERIAUX SIMC
      Président

      ZONE ARTISANALE LES CHALUS 04300 FORCALQUIER

      MATERIAUX SIMC
      Président

      743 BD ST EXUPERY 83300 DRAGUIGNAN

      MATERIAUX SIMC
      Président

      CHE DE DRAGUIGNAN FREJUS 83510 LORGUES

      MATERIAUX SIMC
      Président

      5 BD DE LA MAISON BLANCHE 13014 MARSEILLE 14

      MATERIAUX SIMC
      Président

      RTE NATIONALE 97 83210 SOLLIES PONT

      MATERIAUX SIMC
      Président

      ZI ST MARTIN 83400 HYERES

      MATERIAUX SIMC
      Président

      RTE NATIONALE 8 83190 OLLIOULES

      MATERIAUX SIMC
      Président

      PIERREDON 83110 SANARY SUR MER

      MATERIAUX SIMC
      Président

      861 AV DE L AMANDIER 84000 AVIGNON

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      SAINT JOSEPH 04100 MANOSQUE

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      QUAI LES BOUILLOTES 04700 ORAISON

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      PUYRICARD 13540 AIX EN PROVENCE

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      141 AV DU GENERAL LECLERC 13880 VELAUX

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      QUAI DE MOUGNE 84390 SAULT

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      QUA NAPOLLON 13400 AUBAGNE

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      LA TAPY 84170 MONTEUX

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      AV DES ENTREPRENEURS 83560 VINON SUR VERDON

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      LES MEILLERES 84160 CADENET

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      CHE DES ESCAMPADES 84170 MONTEUX

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      QUARTIER SUR CRAPONNE 13113 LAMANON

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      LES MIANS 84260 SARRIANS

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      370 CHE DES PLAINES 06370 MOUANS SARTOUX

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      1277 RTE D AIX EN PROVENCE 84120 PERTUIS

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      AV DU TUBE 13800 ISTRES

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      AV DE DRAGUIGNAN 83130 LA GARDE

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      ZI QUATRIEME AVENUE 13127 VITROLLES

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      115 CHE VICINAL DE LA MILLIERE ST MENET 13011 MARSEILLE 11

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      QUARTIER CHAPUS 13590 MEYREUIL

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      QUA LES COLONNES 04500 RIEZ

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      ZONE ARTISANALE 04130 VOLX

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      ZONE ARTISANALE LES CHALUS 04300 FORCALQUIER

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      743 BD ST EXUPERY 83300 DRAGUIGNAN

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      CHE DE DRAGUIGNAN FREJUS 83510 LORGUES

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      5 BD DE LA MAISON BLANCHE 13014 MARSEILLE 14

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      RTE NATIONALE 97 83210 SOLLIES PONT

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      ZI ST MARTIN 83400 HYERES

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      RTE NATIONALE 8 83190 OLLIOULES

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      PIERREDON 83110 SANARY SUR MER

      MATERIAUX SIMC
      Administrateur

      861 AV DE L AMANDIER 84000 AVIGNON

      FARAGO AUDE
      Gérant

      SAUTES LE HAUT 11000 CARCASSONNE

      FARAGO AUDE
      Gérant

      10 RUE DE LA GARE 11150 BRAM

      DRAC OPTIQUE
      Co-gérant

      20 PL DU 8 MAI 1945 38800 LE PONT DE CLAIX

      SUNKISS MATHERM RADIATION
      Président du conseil d`administration

      CHE DES VIGNES 01360 BRESSOLLES

      SECURITE INCENDIE MONTAGE
      Administrateur

      62 RUE ERNEST RENAN 92000 NANTERRE

      SECURITE INCENDIE MONTAGE
      Administrateur

      15 AV DU MARECHAL JOFFRE 92000 NANTERRE

      SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN FOURNITURES INDUSTRIELLES
      Président

      5 RUE FERRIE 95300 ENNERY

      EARL DES POTIERS
      Co-gérant

      3 RUE DES POTIERS 60220 BOUVRESSE

      SCEA CHAUDESAIGUES
      Co-gérant

      L'ESPINELLE 11400 SAINT PAPOUL

      SCEA CHAUDESAIGUES
      Associé-gérant

      L'ESPINELLE 11400 SAINT PAPOUL

      COVEBAT
      Administrateur

      1 SQ DU 1ER ZOUAVE 69480 ANSE

      OPTIPHARM
      Administrateur

      159 AV DE VERDUN 36000 CHATEAUROUX

      OPTIPHARM
      Administrateur

      RUE AIME COTTON 19100 BRIVE LA GAILLARDE

      MATERIAUX ET BETONS DU NORD
      Gérant

      RUE PORT FLUVIAL 1ERE AVE 59250 HALLUIN

      SOGETHA
      Président

      54 RTE DE LA LUYE 05000 GAP

      SOGETHA
      Président

      54 RTE DE LA LUYE 05000 GAP

      SKM INDUSTRIE
      Président

      CHE DES VIGNES 01360 BRESSOLLES

      ARMOR COURTAGE
      Gérant

      50 RUE DU PDT ROBERT SCHUMAN 35400 SAINT MALO

      SCI ESTELLE
      Gérant

      11 RES DES CENTS ARPENTS 77910 GERMIGNY L'EVEQUE

      SAINT MARTIN DISTRIBUTION
      Président

      1 RUE TURGOT 27150 ETREPAGNY

      ALLIANCE IMMOBILIER
      Administrateur

      26 RUE GAMBETTA 54400 LONGWY

      ALLIANCE IMMOBILIER
      Administrateur

      2 RUE THOMAS EDISON 57070 METZ

      ALLIANCE IMMOBILIER
      Administrateur

      56 RUE BEARN 54400 COSNES ET ROMAIN

      SCI OPTI 2
      Gérant

      159 AV DE VERDUN 36000 CHATEAUROUX

      CO.GE.CO COOP GESTION ET CONSTRUCTION
      Administrateur

      13 RUE D'AUVERGNE 41000 BLOIS

      CO.GE.CO COOP GESTION ET CONSTRUCTION
      Administrateur

      13 RUE D'AUVERGNE 41000 BLOIS

      EARL LE PENILLOUX
      Gérant

      1 CHE DU PERRIER 38460 SOLEYMIEU

      EARL LE PENILLOUX
      Gérant

      1 CHE DU PERRIER 38460 SOLEYMIEU

      LIBAULT
      Directeur général

      28 RUE DE LA ROTONDE 58000 NEVERS

      LIBAULT
      Administrateur

      28 RUE DE LA ROTONDE 58000 NEVERS

      LIBAULT
      Administrateur

      28 RUE DE LA ROTONDE 58000 NEVERS

      QUADRAL PROMOTION
      Administrateur

      12 RUE FRANCOIS DE CUREL 57000 METZ

      QUADRAL PROMOTION
      Administrateur

      50 AV CLAUDE VELLEFAUX 75010 PARIS 10

      QUANTA SERVICE
      Gérant

      31 AV DE BURES 91440 BURES SUR YVETTE

      CHATEAU MERIC
      Gérant

      CHATEAU MERIC 33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC

      S.A.S SOLOCHAR
      Gérant

      MOULIN DE LA GIRAUDIERE 41220 VILLENY

      SOC INDUSTRIELLE MATERIAUX CONSTRUCTION
      Administrateur

      SAINT JOSEPH 04100 MANOSQUE

      ALEXA SARL
      Gérant

      31 RUE HENRI GORJUS 69004 LYON 4EME

      LES VIGNERONS D'UNI-MEDOC
      Administrateur

      14 RTE DE SOULAC 33340 GAILLAN EN MEDOC

      LES VIGNERONS D'UNI-MEDOC
      Administrateur

      23 RUE DES COLOMBIERS 33340 PRIGNAC EN MEDOC

      LES VIGNERONS D'UNI-MEDOC
      Administrateur

      27 CHE DE LA CAVE 33340 QUEYRAC

      LES VIGNERONS D'UNI-MEDOC
      Administrateur

      2 RTE DE CANISSAC 33340 BEGADAN

      LES VIGNERONS D'UNI-MEDOC
      Administrateur

      PAVILLON BELLEVUE 33340 ORDONNAC

      M.N.M.C.G.
      Co-gérant

      RASCLAOUZASSE 30140 TORNAC

      LES LILAS MAUVES
      Associé-gérant

      106 CHE RECHERCHANT CD28 97432 SAINT PIERRE

      MARICA
      Gérant

      55 RUE PARADIS 13006 MARSEILLE 6

      LES SABLONS
      Associé-gérant

      LE MOULIN NEUF 44760 LA BERNERIE EN RETZ

      LES SABLONS
      Associé-gérant

      LES SABLONS 28260 GUAINVILLE

      Etat juridique de : LIBAULT

      IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
      Nom ou raison sociale de l'entreprise LIBAULT
      Entrepreneurs individuels LIBAULT
      Identifiant de l'entreprise 711880229
      Numéro interne du siège 00028
      Adresse 28 RUE DE LA ROTONDE 58000 NEVERS
      CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE
      Origine de la création de l'établissement Création (pour tout type de déclaration)
      Année et mois de création de l'établissement lundi 01 janvier 1990
      Tranche d'effectif salarié de l'établissement 6 à 9 salariés
      Effectif salarié de l'établissement à la centaine près 6
      CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
      Nature juridique de l'entreprise SAS, société par actions simplifiée
      Tranche d'effectif de l'entreprise 6 à 9 salariés
      Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près 6
      Catégorie d'entreprise Petite ou Moyenne Entreprise
      Année et mois de création de l'entreprise lundi 01 janvier 1968
      Tranche de chiffre d'affaires Non renseignée
      Dernier CA connu (2014) 651 347,00
      Résultat net -11 274,00
      Activité
      Indice de monoactivité de l'entreprise Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale
      Modalité de l'activité principale de l'entreprise Activité simple
      Caractère productif de l'entreprise Productif
      Activité principale du siège 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
      Activité principale de l'entreprise 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
      Activité principale au registre des métiers 4322AZ
      Activité au siege
      Secteur immobilier
      Catégorie BTP et construction
      Activite Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
      Synonyme plombier, installateur de gaz
      Principal plombier
      Voir la fiche Sirene de LIBAULT

      Données comptables de LIBAULT

      Actif au bilan
      Année 2014
      Actif immobilisé 477 810
      Immobilisation incorporelle 483
      Immobilisation corporelle 476 129
      Immobilisation financière 1 198
      Actif circulant net 626 372
      Stock 25 762
      Avance 0
      Créance 116 334
      Placement 484 276
      Total Actif 1 104 184


      Passif au bilan
      Capitaux propre 532 679
      Autres fonds 0
      Provision 0
      Dette 571 502
      Total Passif 1 104 181


      Compte de résultat
      Chiffre d'affaire 651 347
      Produit d'exploitation 687 141
      Charge d'exploitation 698 963
      Résultat d'exploitation -11 822
      Produit financier net 11 358
      Charge financière 12 942
      Résultat financier -1 584
      Résultat courrant -13 406
      Produit exceptionnel 0
      Charges exceptionnelles 0
      Résultat exceptionnel 0
      Résultat net -11 274

      Carte

      Etablissements de LIBAULT

      Siret Etablissement
      71188022900028 LIBAULT 28 RUE DE LA ROTONDE 58000 NEVERS FRANCE

      Greffe de LIBAULT

      LIBAULT est du ressort du greffe de NEVERS dont les coordonnées postales sont 19 RUE SAINT MARTIN 58020 NEVERS CEDEX
      Le greffe peut être appelé au 03 86 61 06 71 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nevers.fr.
      Les greffiers sont : DOUCEDE Donatienne , DUNOYER Pierre-Emile
      Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h

      Conventions collectives de LIBAULT

      Les conventions collectives applicables à LIBAULT de part son activité de 4322A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux) sont :
      • 02420 Bâtiment cadres
      • 02609 Bâtiment ETAM
      • 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
      • 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
      • Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1

      Timeline des événements et des actes de LIBAULT

      Depot des comptes 22 avril 2008
      Cloture du 2007-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 20 novembre 2008
      Cloture du 2008-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 06 octobre 2009
      Modification survenue sur l'administration
      Président directeur général : CHAMON Pierre Administrateur : CHAMON Michèle Marthe Judith né(e) ROLLAND Administrateur : CHAMON Sarah Agnès Commissaire aux comptes titulaire : STE COGEP représenté par MENUEL Philippe Commissaire aux comptes suppléant : REYNE Paul
      Depot des comptes 16 décembre 2009
      Cloture du 2009-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 03 novembre 2010
      Cloture du 2010-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 09 mars 2011
      Modification survenue sur l'administration
      Président directeur général et administrateur : CHAMON Michèle né(e) ROLLAND Directeur général délégué et administrateur : CHAMON Pierre Administrateur : CHAMON Sarah, Agnès Commissaire aux comptes titulaire : STE COGEP représenté par MENUEL Philippe Commissaire aux comptes suppléant : REYNE Paul
      Depot des comptes 26 novembre 2011
      Cloture du 2011-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 07 décembre 2012
      Cloture du 2012-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 27 novembre 2013
      Modification survenue sur l'administration
      Président, Directeur général, Administrateur : CHAMON Michèle né(e) ROLLAND Directeur général délégué, Administrateur : CHAMON Pierre Administrateur : CHAMON Sarah, Agnès Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT -SAS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : REYNE Paul
      Depot des comptes 02 décembre 2013
      Cloture du 2013-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 10 novembre 2014
      Cloture du 2014-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 24 novembre 2015
      Cloture du 2015-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 26 octobre 2016
      Cloture du 2016-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 24 mai 2017
      Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration
      Président : CHAMON Michèle né(e) ROLLAND
      Depot des comptes 09 novembre 2017
      Cloture du 2017-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 13 novembre 2018
      Cloture du 2018-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Modification 16 novembre 2018
      modification survenue sur l'administration
      Président partant : Rolland, nom d'usage : Chamon, Michèle ; nomination du Président : Chamon, Vincent
      Depot des comptes 05 décembre 2019
      Cloture du 2019-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Depot des comptes 27 septembre 2022
      Cloture du 2022-03-31
      Comptes annuels et rapports
      Voir les événements bodacc de LIBAULT

      BRUN DELPHINE
      HOLDING COSTA
      AHMETOVIC NEDELJKO
      DESTREZ MICHEL
      ARCHE CONSTRUCTION
      CASTAGNE LAURENCE JACQUELINE