31/01/2008 |
FIDUBEL
434037065 -
Société par actions simplifiée
|
Modification survenue sur l'administration
Président : LE DU Alain Léon Joseph. Président du Conseil de Surveillance : LE DU Marie-Jacqueline né(e) EDIER. Vice-Président du Conseil de Surveillance : LE DU Claire. Membre du Directoire : LEVACHER Henri Rêné André. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES (). Membre du Conseil de Surveillance : LE DU Philippe Léon. Commissaire aux comptes suppléant : YZAMMBART Philippe.
|
|
31/01/2008 |
FIDEVAL
434037230 -
Société par actions simplifiée
|
Modification survenue sur l'administration
Président : LE DU Alain Léon Joseph. Directeur général : LE DU Marie-Jacqueline né(e) EDIER. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES (). Commissaire aux comptes suppléant : YZAMBART Philippe.
|
|
31/01/2008 |
LA GAMBILLE
326794823 -
Société coopérative de consommation anonyme à capital variable
|
Modification survenue sur l'administration
Membre du Conseil de Surveillance : CITOT Didier Roland François. Président du Conseil de Surveillance : CLAESSENS Blandine Béatrice. Directeur général unique : MORELLE Marc Michel André. Membre du Conseil de Surveillance : LE GOFFIC Jocelyne Nelly Anne-Marie. Vice-Président du Conseil de Surveillance : LEMOINE Pierrick Rêné Emile. Commissaire aux comptes titulaire : SA GEIREC (). Commissaire aux comptes suppléant : BAREL Pierre. Membre du Conseil de Surveillance : SAINTILAN Jean-Bernard Francis. Membre du Conseil de Surveillance : BULLIER LAURENT. Membre du Conseil de Surveillance : BARON STEPHANE ANDRE MARCEL.
|
|
31/01/2008 |
SCI NEPTUNE
448832006 -
Société civile Capital : 4 500,00 EUR
|
Modification survenue sur le capital, l'administration
Gérant associé : PASCAL Francois-Jacques Jean-Marie. Gérant associé : OLIVAUD Bruno Marie-Joseph. Gérant associé : BERNARD Louis-Marie Jacques. Gérant associé : ETIENNE Pierre-Luc. Gérant associé : MARCHI Olivier Robert. Gérant associé : LEROYER Laurence Marie-Elisabeth né(e) MONVOISIN. Gérant associé : LAMEZEC Bruno. Gérant associé : HARDY Anne-Claire Isabelle né(e) BESSARD. Gérant associé : PROVOST Patricia Odile Marie né(e) BURBAN. Gérant associé : HASBINI Ali. Gérant associé : BESSON DOMINIQUE IRMA MARIE JOSE. Gérant associé : MARQUE BERNARD YVES GEORGES.
|
|
31/01/2008 |
ELEVAGE DE LA BOURDONNIERE
387486012 -
Exploitation agricole à responsabilité limitée Capital : 228 000,00 EUR
|
Modification survenue sur le capital
|
|
31/01/2008 |
EARL DE L'HYVERY
441299781 -
Exploitation agricole à responsabilité limitée
|
Modification survenue sur l'administration
Gérant(e) : TARDIVEL Patrick Jean-Baptiste Ange-Marie.
|
|
31/01/2008 |
CELTICS CHADENN LIMITED
438121543 -
Société de droit étranger
|
Modification survenue sur l'administration
Représentant de société étrangère : CAOUISSIN YANN VARI KORENTIN-KEO.
|
|
31/01/2008 |
GERANNE
342136447 -
Société à responsabilité limitée
|
Cessation d'activité
|
|
31/01/2008 |
SOCIETE DE CONDITIONNEMENT ET D'ABATTAGE DE VOLAILLES
496380239 -
Société anonyme à conseil d'administration
|
Modification survenue sur l'administration
Président du Conseil d'Administration : CAOULAN Albert. Directeur général et administrateur : CAOULAN Patricia. Directeur général délégué et administrateur : LATOUCHE Michel Yves André. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COLIN-HENRIO (). Commissaire aux comptes suppléant : OUEST CONSEILS AUDIT ().
|
|
|
31/01/2008 |
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELAPERRUQUE
381511542 -
Société civile
|
Modification survenue sur l'administration
Gérant associé : JAN NICOLLE MARIE JULIETTE né(e) DELAPERRUQUE.
|
|
31/01/2008 |
SCI MAISON DIOCESAINE DE RETRAITE
388340838 -
Société civile immobilière
|
Modification survenue sur l'administration
Gérant(e) : ABIVEN MARCEL FELIX MARIE.
|
|
31/01/2008 |
TAOL SARL
485125207 -
Société à responsabilité limitée
|
Dissolution de la société
Liquidateur : SOHIER Yann Erwan.
|
|
31/01/2008 |
DECO DIFFUSION
338484850 -
Société à responsabilité limitée
|
Dissolution de la société
Liquidateur : RIVOALLAN Marie-Andrée Jeanne né(e) PEDRON.
|
|
31/01/2008 |
JCS
492017900 -
Société par actions simplifiée Capital : 69 000,00 EUR
|
Modification survenue sur le capital
|
|
31/01/2008 |
S.C.I. LA CORDERIE
384224176 -
Société civile immobilière
|
Modification survenue sur l'administration
Gérant(e) : ABIVEN MARCEL FELIX MARIE.
|
|
31/01/2008 |
EARL TANGUY
404181695 -
Exploitation agricole à responsabilité limitée
|
Dissolution de la société
Liquidateur : TANGUY Bernard.
|
|
31/01/2008 |
Nico et Céline
492550199 -
Société à responsabilité limitée
|
Dissolution de la société
Liquidateur : ZALEWSKI Nicolas Christian Eric.
|
|
31/01/2008 |
MAISON MEDICALE LA HARDOUINAIS
435085758 -
Société civile de moyens
|
Transfert du siège social
8 rue de Brocéliande 22230 Merdrignac |
|
31/01/2008 |
SOCIETE PAIMPOLAISE DE CARTONNAGES
379350481 -
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
|
Dissolution de la société
Liquidateur : LE GONNIDEC Bernard.
|
|
|
31/01/2008 |
SCCV DES COLVERTS
428855076 -
Société civile de construction / vente
|
Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social
Gérant associé : LE PERSON NATHALIE JACQUELINE MARIE PAULE né(e) CAMARD.
3 RUE DES GRANDES PATURES 22120 Yffiniac |
|
31/01/2008 |
SAINT GEORGES
450572854 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification survenue sur l'administration
Gérant(e) : MORICE Frédéric Michel. Gérant(e) : LE PERDU CAROLE JEANNE LILIANE.
|
|
31/01/2008 |
FONCIERE et DEVELOPPEMENT INGENIERIE
442132395 -
Société par actions simplifiée
|
Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
Président : LEBLON GEORGES-MARIE ANATOLE ALBERT. Directeur général délégué : DEVAUX JEAN-CLAUDE PAUL MARIE GHISLAIN. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (). Commissaire aux comptes suppléant : ANSART Michel.
|
|
31/01/2008 |
SANIT ENERGIE
439505132 -
Société à responsabilité limitée
|
Transfert du siège social
16 rue DES GREVES 22120 Hillion |
|
31/01/2008 |
COLEB
453790701 -
Société à responsabilité limitée
|
Transfert du siège social
3 RUE CHARLES PRADAL 22000 Saint-Brieuc |
|
31/01/2008 |
MAGE
499901064 -
Société à responsabilité limitée
|
Mise en activité de la société
|
|
31/01/2008 |
BRETAGNE DUNET STORES
316694785 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
Gérant(e) : DUNET Xavier. Gérant(e) : DUNET Olivier Armand.
|
|
31/01/2008 |
CALORIS
431760198 -
Société à responsabilité limitée
|
Dissolution de la société
Gérant(e) : FROMENTIN Bernard Léon Joseph Marie. Liquidateur : FROMENTIN Bernard.
|
|
31/01/2008 |
C.A.L.I.P.S.E.
350653689 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification survenue sur la dénomination et reprise de l'activité après suspension
|
|
31/01/2008 |
SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES
422805655 -
Société à responsabilité limitée Capital : 97 680,00 EUR
|
Modification survenue sur le capital, l'administration
Gérant(e) : PARIS Alain Louis Jacques. Gérant(e) : BALANANT Jean-Claude. Gérant(e) : DENIS Philippe Paul Michel. Gérant(e) : STEUNOU Gilles Francis Marie Mathurin. Gérant(e) : IMBERT Agnès. Gérant(e) : GLEZ Carole né(e) PAUTREL. Commissaire aux comptes titulaire : RENN EX.CO (). Commissaire aux comptes suppléant : CHATEL Philippe.
|
|
|
31/01/2008 |
LE FLOCH TP
430011593 -
Société à responsabilité limitée
|
Cessation d'activité
|
|
31/01/2008 |
J.M.C.
414924076 -
Société par actions simplifiée
|
Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
Président : FUTURA (SARL). Commissaire aux comptes titulaire : MAZEAU JEAN-CLAUDE. Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION ().
|
|
31/01/2008 |
JEGOUIC et FILLE
453337487 -
Société en nom collectif
|
Cessation d'activité
|
|
31/01/2008 |
BERNARD JAN
496980418 -
Société anonyme à conseil d'administration
|
Modification survenue sur l'administration
Président directeur général : JAN Frédéric Marc Robert. Administrateur : JAN Thierry. Administrateur : JAN Robert. Commissaire aux comptes titulaire : GUILLOU Jean-Louis. Commissaire aux comptes suppléant : ANDREOLI Alain.
|
|
31/01/2008 |
CLINIQUE ARMORICAINE DE RADIOLOGIE
496980426 -
Société à responsabilité limitée Capital : 454 400,00 EUR
|
Modification survenue sur le capital, l'administration
Gérant(e) : OLIVAUD Bruno. Gérant(e) : PASCAL François. Gérant(e) : BERNARD Louis-Marie. Gérant(e) : ETIENNE Pierre-Luc. Gérant(e) : MARCHI Olivier Robert. Gérant(e) : LEROYER Laurence Marie-Elisabeth Juliette né(e) MONVOISIN. Gérant(e) : LAMEZEC Bruno. Gérant(e) : HARDY Anne-Claire Isabelle né(e) BESSARD. Gérant(e) : PROVOST Patricia Odile Marie né(e) BURBAN. Gérant(e) : HASBINI Ali. Gérant(e) : BESSON DOMINIQUE IRMA MARIE JOSE. Gérant(e) : MARQUE BERNARD YVES GEORGES. Commissaire aux comptes titulaire : COURROYE Yves. Commissaire aux comptes suppléant : WANAVENBECQ Sylvie.
|
|
31/01/2008 |
GROUPE MEDICAL DE LA CLINIQUE ARMORICAINE DE RADIOLOGIE
449962463 -
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
|
Modification survenue sur le capital
|
|
31/01/2008 |
GENPONTI
482718921 -
Société civile immobilière
|
Modification survenue sur l'administration
Gérant(e) : CADOUDAL CLERICE Gilles Georges.
|
|
31/01/2008 |
SPERIAN PROTECTION ARMOR
497180695 -
Société par actions simplifiée
|
Modification survenue sur l'administration
Président : FAVALETTO BRUNO HUGUES FRANCK. Directeur général : BELLIER Jean-Noël Alfred Louis. Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT (SACA) représenté par COLLOMB Patrick. Commissaire aux comptes suppléant : BURRIER Jérôme.
|
|
31/01/2008 |
LES FERMIERS DE BRETAGNE
399253962 -
Société anonyme à conseil d'administration
|
Modification survenue sur l'administration
Président directeur général et administrateur : LORET Rêne Jean-Paul Eugène. Directeur général adjoint : GUILLOME Gilbert Louis-Marie. Administrateur : C.D.P.O. () représenté par PHILIPPE Jean-Marc Guy Luc. Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS () représenté par EOUZAN Louis Jean-François-André. Administrateur : PHILIPPE Dominique Marie Jean-Marc. Commissaire aux comptes titulaire : LE GUILLON Geneviève. Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Yannick.
|
|
31/01/2008 |
EARL DU BOURG
492514658 -
Exploitation agricole à responsabilité limitée Capital : 126 000,00 EUR
|
Modification survenue sur le capital, l'administration
Gérant(e) : LE POTTIER Franck Michel Alexandre Marie. Gérant(e) : LE POTIER Lynda Réjane Marie.
|
|
|
31/01/2008 |
Sarl ARIANE AUTO-ECOLE
493759674 -
Société à responsabilité limitée
|
Transfert du siège social
16 RUE PIERRE LOTI 22580 Plouha |
|
31/01/2008 |
TFE SAINT-BRIEUC
344574264 -
Société par actions simplifiée unipersonnelle
|
Modification survenue sur la dénomination, le nom commercial
|
|
31/01/2008 |
GARAGE DE LA TRINITE
398435693 -
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
|
Modification survenue sur l'activité
|
|
31/01/2008 |
SARL TARDIVEL
448480608 -
Société à responsabilité limitée
|
Dissolution de la société
Liquidateur : TARDIVEL Daniel Armand Jean Pierré.
|
|
31/01/2008 |
STEPHIL
410333553 -
Société à responsabilité limitée
|
Cessation d'activité de la société
|
|
31/01/2008 |
SARL LA PENTHIEVRE
489943654 -
Société civile immobilière
|
Modification survenue sur la forme juridique, la dénomination, l'activité
|
|
31/01/2008 |
TRANSPORTS COLLONG PERE ET FILS
500701172 -
Société à responsabilité limitée
|
Mise en activité de la société
|
|
31/01/2008 |
TERRE D'ISLANDE
379767874 -
Société à responsabilité limitée
|
Transfert du siège social
26 place du Martray 22500 Paimpol |
|
31/01/2008 |
ETABLISSEMENTS MORICE
410735831 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification survenue sur l'activité
|
|
31/01/2008 |
SOCIETE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE
777456153 -
Société anonyme à conseil d'administration
|
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Administrateur : LE ROUX Paul Jean. Administrateur : NEVEU Christophe. Administrateur : CILCA () représenté par BALAVOINE Michel. Administrateur : CREDIT IMMOBILIER DU MORBIHAN () représenté par DROUAL Jean. Administrateur : MONNIER Auguste. Administrateur : ESPACIL HABITAT () représenté par ALLAIN Joseph. Administrateur : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE () représenté par DAVID Alain. Administrateur : CAISSE INTERFEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE () représenté par POUPON Alain Marcel. Administrateur : DAGORN Aimé François-Marie. Administrateur : ANGER Michel. Administrateur : VIMONT Pierre-François. Administrateur : CIL HABITAT OUEST () représenté par GUERIN Daniel Ferdinand Antonin. Administrateur : HENRY Régis Raymond Paul Marie-Joseph. Administrateur : GALLAIS Alain Eugène Robert Marcel. Administrateur : LAMY LUCIENNE MARIE né(e) LE TACON. Administrateur : RENAULT JEAN YVES MATHURIN. Commissaire aux comptes titulaire : SCP ROUXEL-TANGUY (SCP). Commissaire aux comptes titulaire : EURL BECQUARD (). Commissaire aux comptes suppléant : LEPAGE Gilbert. Commissaire aux comptes suppléant : TANGUY Michel.
|
|
31/01/2008 |
SARL MILCOUP
417638301 -
Société à responsabilité limitée
|
Cessation d'activité
|
|