31/10/2008 |
ABDESSEMED Houari
500464318 -
Société en nom personnel
|
Modification de l'adresse de l'établissement. Modification de l'activité.
Personne infiniment responsable : ABDESSEMED Houari
10 rue Alphonse Dupeux 33000 Bordeaux |
|
31/10/2008 |
KERBOUCHE Nouredine
482373784 -
Société en nom personnel
|
Modification de l'adresse de l'établissement. Modification de l'activité.
Personne infiniment responsable : KERBOUCHE Nouredine
1 rue Tombe Loly 33000 Bordeaux |
|
31/10/2008 |
M. CREA
504364514 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de l'adresse du siège.
199 avenue du Médoc 33320 Eysines |
|
31/10/2008 |
RIDERS & CO DESTOCK
479456238 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de représentant. Modification de l'activité.
Gérant : ACEBRON Bruno modification le 22 Octobre 2008.
|
|
31/10/2008 |
EXALAB
323191106 -
Société d'exercice libéral en commandite par actions Capital : 1 535 100,00 EUR
|
Modification du capital. Modification de représentant.
Associé commandité gérant : RICHARD Laurence Marcelle Jacqueline modification le 13 Mars 2006. Associé commandité gérant : BROCHET Jean Philippe modification le 13 Mars 2006. Associé commandité gérant : LE MOIGNE Bernard Yves modification le 17 Mars 2006. Associé commandité gérant : BONNIN Pascal Marc modification le 13 Mars 2006. Commissaire aux comptes titulaire : SA FIGEOR en fonction le 23 Avril 1997. Commissaire aux comptes suppléant : CHARPENTIER Michel en fonction le 23 Avril 1997. Associé commandité gérant : DE BARRAU DE MURATEL Maurice Cyr Guy modification le 17 Mars 2006. Associé commandité gérant : DELPECH Richard Pierre Philippe modification le 17 Mars 2006. Associé commandité gérant : VIGNAUX Delphine Agnès Béatrice modification le 17 Mars 2006. Associé commandité gérant : DOERMANN Franck Frédéric modification le 13 Mars 2006. Associé commandité gérant : DAVID Pierre Olivier modification le 17 Mars 2006. Associé commandité gérant : CHABROL Anne Monique Marie modification le 13 Mars 2006. Membre du conseil de surveillance : MARTIN Laurence en fonction le 22 Octobre 2008. Membre du conseil de surveillance : WALRYCK Hervé en fonction le 22 Octobre 2008. Membre du conseil de surveillance : DARMAILLAC Valérie en fonction le 22 Octobre 2008.
|
|
31/10/2008 |
INDO' RR COACH MANAGEMENT
411106701 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de représentant.
Gérant : DE VILLENEUVE BARGEMONT Philippe en fonction le 22 Octobre 2008.
|
|
31/10/2008 |
DIRECTION ET PRIORITES S A
339450249 -
Société par actions simplifiée
|
Modification de représentant.
Président : CHASTENET BERTRAND, JEAN, JEROME, HENRI modification le 04 Janvier 2005. Commissaire aux comptes suppléant : MIANE François en fonction le 22 Octobre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GEORGES SCHELL en fonction le 22 Octobre 2008.
|
|
31/10/2008 |
OBIK
492374467 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de représentant.
Gérant : DODO Idriss Jean-Paul en fonction le 15 Mars 2007. Gérant : BEY Karim Nicolas en fonction le 15 Mars 2007.
|
|
31/10/2008 |
NOUVELLE ENTREPRISE DE COUVERTURE ET DE FACADE
495347395 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de l'adresse du siège.
55 a rue de Garies 33700 Mérignac |
|
|
31/10/2008 |
SARL AD
449016435 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de l'adresse du siège.
7 rue Ariane Zone Artisanale de Toussaint Catros Il 33185 Le Haillan |
|
31/10/2008 |
NOLEX
499542538 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de l'adresse du siège.
55 rue Camille Pelletan 33150 Cenon |
|
31/10/2008 |
SCI BRUNET
382397255 -
Société civile immobilière
|
Modification de l'adresse du siège.
7 allée Labarthe 33110 Le Bouscat |
|
31/10/2008 |
SOCIETE GENERALE D'INGENIERIE DE CHARPENTE ET DE CONSTRUCTION
382605517 -
Société à responsabilité limitée Capital : 30 000,00 EUR
|
Modification du capital.
|
|
31/10/2008 |
BOUSCAPAIN
410916936 -
Société à responsabilité limitée
|
Dissolution de la société.
Liquidateur : PETIET Rene Gerard Antoine modification le 22 Octobre 2008.
|
|
31/10/2008 |
SEGEM S. A. S
472202225 -
Société par actions simplifiée
|
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : BRG AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 17 Décembre 2002. Président : FROUIN Hervé en fonction le 30 Avril 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CARLES Denis en fonction le 22 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE AQUITAINE DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 22 Octobre 2008.
|
|
31/10/2008 |
SOCIETE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE
338681745 -
Société par actions simplifiée Capital : 500 000,00 EUR
|
Modification du capital.
|
|
31/10/2008 |
GASTRONOME ET COMPAGNIE
491384897 -
Société à responsabilité limitée
|
Cessation d'activité de la société à compter du 3 octobre 2008.
|
|
31/10/2008 |
LE PRIVILEGE
497833681 -
Société civile de construction vente (loi de 1971) titre 1
|
Modification de représentant.
Gérant non associé : PORCHERON Philippe. Associé : VEALIS Développement représenté par MONGIS Julien. Associé : VEALIS représenté par MONGIS Julien. Associé : SAS GROUPE PORCHERON représenté par PORCHERON Philippe, Pierre, Hubert.
|
|
31/10/2008 |
KALLYGROUP
489704981 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de l'adresse du siège.
13 place Voltaire 33150 Cenon |
|
|
31/10/2008 |
LE LAGON
491365060 -
Société civile
|
Modification de l'adresse du siège.
34 boulevard Antoine Gautier 33000 Bordeaux |
|
31/10/2008 |
EURA AUDIT CABINET REMY
383567419 -
Société à responsabilité limitée Capital : 144 660,00 EUR
|
Modification du capital. Modification de représentant.
Co-gérant : HIVERT Patrick Serge en fonction le 24 Octobre 2003. Co-gérant : CADREN Jean-Marie Henri modification le 22 Octobre 2008. Co-gérant : LHERM Pascal, Bernard, Marie en fonction le 22 Octobre 2008.
|
|
31/10/2008 |
HIBISCUS AND CO
500062831 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité.
73 rue des Remparts 33000 Bordeaux |
|
31/10/2008 |
JORET PERE ET FILS
413994559 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de représentant.
Gérant : JORET Michael en fonction le 10 Novembre 1997.
|
|
31/10/2008 |
EPAB
419404249 -
Société à responsabilité limitée
|
Cessation d'activité et dissolution de la société.
Liquidateur : BREL Alain modification le 22 Octobre 2008.
|
|
31/10/2008 |
LAYERE LOCATION
424989069 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.
|
|
31/10/2008 |
SOCIETE DU HAUT MEDOC SELECTION
377913751 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de l'adresse du siège.
1 rue d'Enghien 33000 Bordeaux |
|
31/10/2008 |
SPIZZA
501570402 -
Société à responsabilité limitée
|
Cessation d'activité de la société à compter du 24 mai 2008.
|
|
31/10/2008 |
SIRRIUS
453008625 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de l'adresse du siège.
38 rue Guynemer 33290 Blanquefort |
|
31/10/2008 |
SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN
780111357 -
Société par actions simplifiée
|
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : PERRIER Christian modification le 24 Août 2006. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS en fonction le 24 Août 2006. Président : DAVEZAC Robert en fonction le 22 Octobre 2008.
|
|
|
31/10/2008 |
ORTHOPEDIE GRENIE LAPEYRE
408400950 -
Société à responsabilité limitée
|
Modification de représentant.
Gérant : LAPEYRE REGIS, DANIEL, CHRISTIAN. Gérant : GELIN Laurence en fonction le 22 Octobre 2008.
|
|
31/10/2008 |
SETYS
421201872 -
Société à responsabilité limitée Capital : 22 500,00 EUR
|
Modification du capital.
|
|
31/10/2008 |
LOCATION TRANSPORTS IZARET AQUITAINE
309543460 -
Société par actions simplifiée Capital : 252 500,00 EUR
|
Modification du capital.
|
|
31/10/2008 |
ARGOS OIL FRANCE SAS
492203815 -
Société par actions simplifiée Capital : 1 950 000,00 EUR
|
Modification du capital.
|
|
31/10/2008 |
S.N.C. INSEMIA
338165798 -
Société en nom collectif Capital : 142 336,00 EUR
|
Augmentation de capital
Gérant associé en nom : GUILLEVIC Pascale Marie Odile. Gérant associé en nom : RALLE Yves Marcel Michel Marie. Gérant associé en nom : SIMON Christian Marie Raymond Rémi. Associé indéfiniment responsable : GUILLARD Anthony. Associé indéfiniment responsable : NKENGE Duama. Associé indéfiniment responsable : ROUHAUD Mikael. Associé indéfiniment responsable : SEVAMY Arsene. Associé en nom collectif : LE BOTLAN Dominique Pierre. Associé en nom collectif : RANNO Christian Roger. Associé en nom collectif : LE GOFF Bernard Fernand Louis. Associé en nom collectif : LE GOFF Didier Francis Rémi. Associé en nom collectif : MARQUER Pascal Christian Marie. Associé en nom collectif : LE LUC Dominique Jean Marcel. Associé en nom collectif : LE LUC Pierrick Marie Lucien. Associé en nom collectif : LE BIGOT Joël Rémi Marcel. Associé en nom collectif : DESBOIS Christian Guy Marie. Associé en nom collectif : BOITTIAUX Frédéric Jean Marc. Associé en nom collectif : BIHOUEE André Albert Nicole. Associé en nom collectif : CAREL Philippe Jean Noël. Associé en nom collectif : SARL DU BEAU SOLEIL. Associé en nom collectif : BOUSQUET Patrice. Associé en nom collectif : LE ROUZIC Yannick Marie. Associé en nom collectif : SARL DU PALUD. Associé en nom collectif : PAVIC Bernard Georges Marie. Associé en nom collectif : GUEHO Stéphane Michel Marie Joseph. Associé en nom collectif : DREANO Stéphane Alphonse Jean Marie. Associé en nom collectif : JUBIN Michel. Associé en nom collectif : FRELON François Florent. Associé en nom collectif : GALLO Christophe Jean-Claude. Associé en nom collectif : BAREGE Christophe. Associé en nom collectif : GISQUET Sylvain. Associé en nom collectif : ROBERT Christian Jean Yves Angèle. Associé en nom collectif : ANNEZO Hervé Serge. Associé en nom collectif : GEORGEAIS Michel. Associé en nom collectif : LEBON Jean-Marie Raymond Désiré. Associé en nom collectif : PERROT Olivier Marcel Georges. Associé en nom collectif : MAHE Eric. Associé en nom collectif : LENTIN Olivier. Associé en nom collectif : THEVON Thierry Jean-Claude Pierre. Associé en nom collectif : BOSCHE Fabrice Alain. Associé en nom collectif : DUFOUR Sylvain Pierre Maurice. Associé en nom collectif : AVENIER Sébastien Fabrice Gérard Marie. Associé en nom collectif : ROBERT Philippe. Associé en nom collectif : BRUNAT Stephane. Associé en nom collectif : JEANNOT Claude. Associé en nom collectif : LE CALVEZ Jean-Yves. Associé en nom collectif : PARIS Frederic. Associé en nom collectif : MOULAC Yoan. Associé en nom collectif : GUINAUDEAU Simon. Associé en nom collectif : JOSIEN Jerome. Associé en nom collectif : LEHOREAU Sebastien. Associé en nom collectif : GERVAIS Mickael. Associé en nom collectif : HAMONIC Lionel. Associé en nom collectif : LISZEWSKI Franck. Associé en nom collectif : DELSART Emmanuel. Associé en nom collectif : DUCHEMANN Rufin. Associé en nom collectif : LE CLEZIO Emmanuel. Associé en nom collectif : COULEE Jean-Noel. Associé en nom collectif : LEMARIE Didier. Associé en nom collectif : PEREIRA Marie-Noelle. Associé en nom collectif : REUX Olivier. Associé en nom collectif : RIOU Michel. Associé en nom collectif : BEAUCHENE Stephane. Associé en nom collectif : ARGENTIN Cyril. Associé en nom collectif : DIOP Alassane. Associé en nom collectif : MENGUY Marc. Associé en nom collectif : VARGAS QUEIJO Ruben. Associé en nom collectif : VILAIN Cecile. Associé en nom collectif : COLLET Fabienne. Associé en nom collectif : DEMETER Patrick. Associé en nom collectif : KERFILOUE Jerome. Associé en nom collectif : LAVALEUR Johny. Associé en nom collectif : MORICE Damien. Associé en nom collectif : TESSIER Teddy.
Zone Artisanale du Chesnot 35160 Breteil |
|
31/10/2008 |
RENNES COM
326039666 -
Société en nom personnel
|
Changement d'activité Changement de nom commercial
Personne infiniment responsable : VILLENEUVE Daniel
17 Grande rue 35590 L'Hermitage |
|
31/10/2008 |
ETS JEAN HUCHET
306472770 -
Société anonyme à conseil d'administration Capital : 224 000,00 EUR
|
Changement de président du conseil d'administration Changement d'administrateur
Président directeur général : PAUTRIC Francis. Administrateur : MARIN Jocelyne. Administrateur : PAUTRIC Victoria. Commissaire aux comptes titulaire : HODMON Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE. Commissaire aux comptes suppléant : DELAROCHE Bernard. Commissaire aux comptes suppléant : BATON Claude.
316 route de Saint Malo 35000 Rennes |
|
31/10/2008 |
FRANCK MOTOS
380731091 -
Société à responsabilité limitée Capital : 7 622,45 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : BEYER-BONNIARD Franck Marcel Jean.
53 rue du Pont Sec 35133 Lécousse |
|
31/10/2008 |
COMPTOIR DE L'OUEST
384373882 -
Société par actions simplifiée Capital : 406 120,00 EUR
|
Changement de président du conseil d'administration
Président de la société : SOWILL GESTION, représenté par M DIGNE William Jean-Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON. Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE.
9 rue des Cerisiers 35134 Coësmes |
|
31/10/2008 |
MATAVICOL INDUSTRIE
392804654 -
Société à responsabilité limitée Capital : 36 032,00 EUR
|
Changement d'activité
Gérant : FORESTIER Jean-Yves Francis.
le Milly carrefour de la Roche aux Fées 35240 Le Theil-de-Bretagne |
|
|
31/10/2008 |
SCI DE LA CHAPELLE AUX ORESVES
395393952 -
Société civile immobilière Capital : 62 046,75 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement de gérant ancien gérant : PAVIOT Bernard
Gérant associé indéfiniment responsable : PAVIOT Marietta Simone Alberte. Associé indéfiniment responsable : PEPIN Damien. Associé indéfiniment responsable : PEPIN Hélène. Associé indéfiniment responsable : PEPIN Camille.
2 rue Saint Nicolas 35160 Montfort-sur-Meu |
|
31/10/2008 |
FLOVAL
402660484 -
Société par actions simplifiée Capital : 425 100,00 EUR
|
Changement de président directeur général
Président de la société : SIBI, représenté par M LE CALVEZ Loïc. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : BERTHELOT Pierre.
la Rosière 35340 La Bouëxière |
|
31/10/2008 |
SOCIETE MARITIME D'ARMEMENT DE BRETAGNE
441493558 -
Société par actions simplifiée Capital : 124 077 800,00 EUR
|
Augmentation de capital Changement de commissaire aux comptes
Président de la société : SOCIETE ANONYME BRETONNE D'ECONOMIE, représenté par MME PERRAULT Marylise. Directeur général : GIGUET Jean-Michel. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LE TINIER. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GRAND OUEST. Commissaire aux comptes suppléant : HAVENEL Michel. Commissaire aux comptes suppléant : MONNIER Patrick.
283 avenue du Général Patton 35000 Rennes |
|
31/10/2008 |
KEREVAL
442789210 -
Société par actions simplifiée Capital : 100 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Président de la société : TAMOUDI Abdelmoula. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LE BOUGUENEC. Commissaire aux comptes suppléant : BAHON MICHEL.
4 rue Hélène Boucher Z.A.C. de Bellevue 35235 Thorigné-Fouillard |
|
31/10/2008 |
OMEDIC, SOCIETE EN LIQUIDATION
448457895 -
Société à responsabilité limitée Capital : 7 500,00 EUR
|
Dissolution
Liquidateur amiable : FARDOUN Rahife.
45 square Général Paris Bollardière 35000 Rennes |
|
31/10/2008 |
NICO, SOCIETE EN LIQUIDATION
482714417 -
Société civile de construction-vente Capital : 1 000,00 EUR
|
Dissolution
Associé indéfiniment responsable : SOSO. Associé indéfiniment responsable : CONANEC Antony. Liquidateur amiable : CONANEC Antony.
32 rue Jules Vallès 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande |
|
31/10/2008 |
O.C.D.M.
444166607 -
Société à responsabilité limitée Capital : 7 500,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant : LAGRILLE Didier.
rue Blaise Pascal Z.I. de Bellevue 35220 Châteaubourg |
|
31/10/2008 |
HABITATION DE L'OUEST
484043245 -
S.A.R.L. à associé unique Capital : 2 000,00 EUR
|
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Gérant associé unique : AOUINA Khadija.
1 bis rue d'Ouessant BP 96241 35760 Saint-Grégoire 35762 |
|
31/10/2008 |
SARL A.E.M.
485232516 -
Société à responsabilité limitée Capital : 30 000,00 EUR
|
Changement d'activité
Gérant : MAZUREAU Fabrice Georges Jean.
11 rue de la Santé 35000 Rennes |
|
31/10/2008 |
SARL MONTAUBAN IMMOBILIER
490699451 -
Société à responsabilité limitée Capital : 8 000,00 EUR
|
Changement de gérant
Gérant : GAILLARD Gregory.
8 rue du Général de Gaulle 35360 Montauban-de-Bretagne |
|
31/10/2008 |
A.B.D.I.,SOCIETE EN LIQUIDATION
493636989 -
Société à responsabilité limitée Capital : 8 000,00 EUR
|
Dissolution
Liquidateur amiable : IVANOVA Vania.
16 Belle Etoile 35490 Sens-de-Bretagne |
|