Date Société Description Liens
31/10/2008

ABDESSEMED Houari

500464318 - Société en nom personnel

Modification de l'adresse de l'établissement. Modification de l'activité.

Personne infiniment responsable : ABDESSEMED Houari

10 rue Alphonse Dupeux 33000 Bordeaux
31/10/2008

KERBOUCHE Nouredine

482373784 - Société en nom personnel

Modification de l'adresse de l'établissement. Modification de l'activité.

Personne infiniment responsable : KERBOUCHE Nouredine

1 rue Tombe Loly 33000 Bordeaux
31/10/2008

M. CREA

504364514 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège.



199 avenue du Médoc 33320 Eysines
31/10/2008

RIDERS & CO DESTOCK

479456238 - Société à responsabilité limitée

Modification de représentant. Modification de l'activité.

Gérant : ACEBRON Bruno modification le 22 Octobre 2008.

31/10/2008

EXALAB

323191106 - Société d'exercice libéral en commandite par actions
Capital : 1 535 100,00 EUR

Modification du capital. Modification de représentant.

Associé commandité gérant : RICHARD Laurence Marcelle Jacqueline modification le 13 Mars 2006. Associé commandité gérant : BROCHET Jean Philippe modification le 13 Mars 2006. Associé commandité gérant : LE MOIGNE Bernard Yves modification le 17 Mars 2006. Associé commandité gérant : BONNIN Pascal Marc modification le 13 Mars 2006. Commissaire aux comptes titulaire : SA FIGEOR en fonction le 23 Avril 1997. Commissaire aux comptes suppléant : CHARPENTIER Michel en fonction le 23 Avril 1997. Associé commandité gérant : DE BARRAU DE MURATEL Maurice Cyr Guy modification le 17 Mars 2006. Associé commandité gérant : DELPECH Richard Pierre Philippe modification le 17 Mars 2006. Associé commandité gérant : VIGNAUX Delphine Agnès Béatrice modification le 17 Mars 2006. Associé commandité gérant : DOERMANN Franck Frédéric modification le 13 Mars 2006. Associé commandité gérant : DAVID Pierre Olivier modification le 17 Mars 2006. Associé commandité gérant : CHABROL Anne Monique Marie modification le 13 Mars 2006. Membre du conseil de surveillance : MARTIN Laurence en fonction le 22 Octobre 2008. Membre du conseil de surveillance : WALRYCK Hervé en fonction le 22 Octobre 2008. Membre du conseil de surveillance : DARMAILLAC Valérie en fonction le 22 Octobre 2008.

31/10/2008

INDO' RR COACH MANAGEMENT

411106701 - Société à responsabilité limitée

Modification de représentant.

Gérant : DE VILLENEUVE BARGEMONT Philippe en fonction le 22 Octobre 2008.

31/10/2008

DIRECTION ET PRIORITES S A

339450249 - Société par actions simplifiée

Modification de représentant.

Président : CHASTENET BERTRAND, JEAN, JEROME, HENRI modification le 04 Janvier 2005. Commissaire aux comptes suppléant : MIANE François en fonction le 22 Octobre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GEORGES SCHELL en fonction le 22 Octobre 2008.

31/10/2008

OBIK

492374467 - Société à responsabilité limitée

Modification de représentant.

Gérant : DODO Idriss Jean-Paul en fonction le 15 Mars 2007. Gérant : BEY Karim Nicolas en fonction le 15 Mars 2007.

31/10/2008

NOUVELLE ENTREPRISE DE COUVERTURE ET DE FACADE

495347395 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège.



55 a rue de Garies 33700 Mérignac
31/10/2008

SARL AD

449016435 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège.



7 rue Ariane Zone Artisanale de Toussaint Catros Il 33185 Le Haillan
31/10/2008

NOLEX

499542538 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège.



55 rue Camille Pelletan 33150 Cenon
31/10/2008

SCI BRUNET

382397255 - Société civile immobilière

Modification de l'adresse du siège.



7 allée Labarthe 33110 Le Bouscat
31/10/2008

SOCIETE GENERALE D'INGENIERIE DE CHARPENTE ET DE CONSTRUCTION

382605517 - Société à responsabilité limitée
Capital : 30 000,00 EUR

Modification du capital.



31/10/2008

BOUSCAPAIN

410916936 - Société à responsabilité limitée

Dissolution de la société.

Liquidateur : PETIET Rene Gerard Antoine modification le 22 Octobre 2008.

31/10/2008

SEGEM S. A. S

472202225 - Société par actions simplifiée

Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : BRG AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 17 Décembre 2002. Président : FROUIN Hervé en fonction le 30 Avril 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CARLES Denis en fonction le 22 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE AQUITAINE DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 22 Octobre 2008.

31/10/2008

SOCIETE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE

338681745 - Société par actions simplifiée
Capital : 500 000,00 EUR

Modification du capital.



31/10/2008

GASTRONOME ET COMPAGNIE

491384897 - Société à responsabilité limitée

Cessation d'activité de la société à compter du 3 octobre 2008.



31/10/2008

LE PRIVILEGE

497833681 - Société civile de construction vente (loi de 1971) titre 1

Modification de représentant.

Gérant non associé : PORCHERON Philippe. Associé : VEALIS Développement représenté par MONGIS Julien. Associé : VEALIS représenté par MONGIS Julien. Associé : SAS GROUPE PORCHERON représenté par PORCHERON Philippe, Pierre, Hubert.

31/10/2008

KALLYGROUP

489704981 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège.



13 place Voltaire 33150 Cenon
31/10/2008

LE LAGON

491365060 - Société civile

Modification de l'adresse du siège.



34 boulevard Antoine Gautier 33000 Bordeaux
31/10/2008

EURA AUDIT CABINET REMY

383567419 - Société à responsabilité limitée
Capital : 144 660,00 EUR

Modification du capital. Modification de représentant.

Co-gérant : HIVERT Patrick Serge en fonction le 24 Octobre 2003. Co-gérant : CADREN Jean-Marie Henri modification le 22 Octobre 2008. Co-gérant : LHERM Pascal, Bernard, Marie en fonction le 22 Octobre 2008.

31/10/2008

HIBISCUS AND CO

500062831 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité.



73 rue des Remparts 33000 Bordeaux
31/10/2008

JORET PERE ET FILS

413994559 - Société à responsabilité limitée

Modification de représentant.

Gérant : JORET Michael en fonction le 10 Novembre 1997.

31/10/2008

EPAB

419404249 - Société à responsabilité limitée

Cessation d'activité et dissolution de la société.

Liquidateur : BREL Alain modification le 22 Octobre 2008.

31/10/2008

LAYERE LOCATION

424989069 - Société à responsabilité limitée

Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.



31/10/2008

SOCIETE DU HAUT MEDOC SELECTION

377913751 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège.



1 rue d'Enghien 33000 Bordeaux
31/10/2008

SPIZZA

501570402 - Société à responsabilité limitée

Cessation d'activité de la société à compter du 24 mai 2008.



31/10/2008

SIRRIUS

453008625 - Société à responsabilité limitée

Modification de l'adresse du siège.



38 rue Guynemer 33290 Blanquefort
31/10/2008

SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN

780111357 - Société par actions simplifiée

Modification de représentant.

Commissaire aux comptes suppléant : PERRIER Christian modification le 24 Août 2006. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS en fonction le 24 Août 2006. Président : DAVEZAC Robert en fonction le 22 Octobre 2008.

31/10/2008

ORTHOPEDIE GRENIE LAPEYRE

408400950 - Société à responsabilité limitée

Modification de représentant.

Gérant : LAPEYRE REGIS, DANIEL, CHRISTIAN. Gérant : GELIN Laurence en fonction le 22 Octobre 2008.

31/10/2008

SETYS

421201872 - Société à responsabilité limitée
Capital : 22 500,00 EUR

Modification du capital.



31/10/2008

LOCATION TRANSPORTS IZARET AQUITAINE

309543460 - Société par actions simplifiée
Capital : 252 500,00 EUR

Modification du capital.



31/10/2008

ARGOS OIL FRANCE SAS

492203815 - Société par actions simplifiée
Capital : 1 950 000,00 EUR

Modification du capital.



31/10/2008

S.N.C. INSEMIA

338165798 - Société en nom collectif
Capital : 142 336,00 EUR

Augmentation de capital

Gérant associé en nom : GUILLEVIC Pascale Marie Odile. Gérant associé en nom : RALLE Yves Marcel Michel Marie. Gérant associé en nom : SIMON Christian Marie Raymond Rémi. Associé indéfiniment responsable : GUILLARD Anthony. Associé indéfiniment responsable : NKENGE Duama. Associé indéfiniment responsable : ROUHAUD Mikael. Associé indéfiniment responsable : SEVAMY Arsene. Associé en nom collectif : LE BOTLAN Dominique Pierre. Associé en nom collectif : RANNO Christian Roger. Associé en nom collectif : LE GOFF Bernard Fernand Louis. Associé en nom collectif : LE GOFF Didier Francis Rémi. Associé en nom collectif : MARQUER Pascal Christian Marie. Associé en nom collectif : LE LUC Dominique Jean Marcel. Associé en nom collectif : LE LUC Pierrick Marie Lucien. Associé en nom collectif : LE BIGOT Joël Rémi Marcel. Associé en nom collectif : DESBOIS Christian Guy Marie. Associé en nom collectif : BOITTIAUX Frédéric Jean Marc. Associé en nom collectif : BIHOUEE André Albert Nicole. Associé en nom collectif : CAREL Philippe Jean Noël. Associé en nom collectif : SARL DU BEAU SOLEIL. Associé en nom collectif : BOUSQUET Patrice. Associé en nom collectif : LE ROUZIC Yannick Marie. Associé en nom collectif : SARL DU PALUD. Associé en nom collectif : PAVIC Bernard Georges Marie. Associé en nom collectif : GUEHO Stéphane Michel Marie Joseph. Associé en nom collectif : DREANO Stéphane Alphonse Jean Marie. Associé en nom collectif : JUBIN Michel. Associé en nom collectif : FRELON François Florent. Associé en nom collectif : GALLO Christophe Jean-Claude. Associé en nom collectif : BAREGE Christophe. Associé en nom collectif : GISQUET Sylvain. Associé en nom collectif : ROBERT Christian Jean Yves Angèle. Associé en nom collectif : ANNEZO Hervé Serge. Associé en nom collectif : GEORGEAIS Michel. Associé en nom collectif : LEBON Jean-Marie Raymond Désiré. Associé en nom collectif : PERROT Olivier Marcel Georges. Associé en nom collectif : MAHE Eric. Associé en nom collectif : LENTIN Olivier. Associé en nom collectif : THEVON Thierry Jean-Claude Pierre. Associé en nom collectif : BOSCHE Fabrice Alain. Associé en nom collectif : DUFOUR Sylvain Pierre Maurice. Associé en nom collectif : AVENIER Sébastien Fabrice Gérard Marie. Associé en nom collectif : ROBERT Philippe. Associé en nom collectif : BRUNAT Stephane. Associé en nom collectif : JEANNOT Claude. Associé en nom collectif : LE CALVEZ Jean-Yves. Associé en nom collectif : PARIS Frederic. Associé en nom collectif : MOULAC Yoan. Associé en nom collectif : GUINAUDEAU Simon. Associé en nom collectif : JOSIEN Jerome. Associé en nom collectif : LEHOREAU Sebastien. Associé en nom collectif : GERVAIS Mickael. Associé en nom collectif : HAMONIC Lionel. Associé en nom collectif : LISZEWSKI Franck. Associé en nom collectif : DELSART Emmanuel. Associé en nom collectif : DUCHEMANN Rufin. Associé en nom collectif : LE CLEZIO Emmanuel. Associé en nom collectif : COULEE Jean-Noel. Associé en nom collectif : LEMARIE Didier. Associé en nom collectif : PEREIRA Marie-Noelle. Associé en nom collectif : REUX Olivier. Associé en nom collectif : RIOU Michel. Associé en nom collectif : BEAUCHENE Stephane. Associé en nom collectif : ARGENTIN Cyril. Associé en nom collectif : DIOP Alassane. Associé en nom collectif : MENGUY Marc. Associé en nom collectif : VARGAS QUEIJO Ruben. Associé en nom collectif : VILAIN Cecile. Associé en nom collectif : COLLET Fabienne. Associé en nom collectif : DEMETER Patrick. Associé en nom collectif : KERFILOUE Jerome. Associé en nom collectif : LAVALEUR Johny. Associé en nom collectif : MORICE Damien. Associé en nom collectif : TESSIER Teddy.

Zone Artisanale du Chesnot 35160 Breteil
31/10/2008

RENNES COM

326039666 - Société en nom personnel

Changement d'activité Changement de nom commercial

Personne infiniment responsable : VILLENEUVE Daniel

17 Grande rue 35590 L'Hermitage
31/10/2008

ETS JEAN HUCHET

306472770 - Société anonyme à conseil d'administration
Capital : 224 000,00 EUR

Changement de président du conseil d'administration Changement d'administrateur

Président directeur général : PAUTRIC Francis. Administrateur : MARIN Jocelyne. Administrateur : PAUTRIC Victoria. Commissaire aux comptes titulaire : HODMON Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE. Commissaire aux comptes suppléant : DELAROCHE Bernard. Commissaire aux comptes suppléant : BATON Claude.

316 route de Saint Malo 35000 Rennes
31/10/2008

FRANCK MOTOS

380731091 - Société à responsabilité limitée
Capital : 7 622,45 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : BEYER-BONNIARD Franck Marcel Jean.

53 rue du Pont Sec 35133 Lécousse
31/10/2008

COMPTOIR DE L'OUEST

384373882 - Société par actions simplifiée
Capital : 406 120,00 EUR

Changement de président du conseil d'administration

Président de la société : SOWILL GESTION, représenté par M DIGNE William Jean-Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON. Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE.

9 rue des Cerisiers 35134 Coësmes
31/10/2008

MATAVICOL INDUSTRIE

392804654 - Société à responsabilité limitée
Capital : 36 032,00 EUR

Changement d'activité

Gérant : FORESTIER Jean-Yves Francis.

le Milly carrefour de la Roche aux Fées 35240 Le Theil-de-Bretagne
31/10/2008

SCI DE LA CHAPELLE AUX ORESVES

395393952 - Société civile immobilière
Capital : 62 046,75 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement de gérant ancien gérant : PAVIOT Bernard

Gérant associé indéfiniment responsable : PAVIOT Marietta Simone Alberte. Associé indéfiniment responsable : PEPIN Damien. Associé indéfiniment responsable : PEPIN Hélène. Associé indéfiniment responsable : PEPIN Camille.

2 rue Saint Nicolas 35160 Montfort-sur-Meu
31/10/2008

FLOVAL

402660484 - Société par actions simplifiée
Capital : 425 100,00 EUR

Changement de président directeur général

Président de la société : SIBI, représenté par M LE CALVEZ Loïc. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : BERTHELOT Pierre.

la Rosière 35340 La Bouëxière
31/10/2008

SOCIETE MARITIME D'ARMEMENT DE BRETAGNE

441493558 - Société par actions simplifiée
Capital : 124 077 800,00 EUR

Augmentation de capital Changement de commissaire aux comptes

Président de la société : SOCIETE ANONYME BRETONNE D'ECONOMIE, représenté par MME PERRAULT Marylise. Directeur général : GIGUET Jean-Michel. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LE TINIER. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GRAND OUEST. Commissaire aux comptes suppléant : HAVENEL Michel. Commissaire aux comptes suppléant : MONNIER Patrick.

283 avenue du Général Patton 35000 Rennes
31/10/2008

KEREVAL

442789210 - Société par actions simplifiée
Capital : 100 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Président de la société : TAMOUDI Abdelmoula. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LE BOUGUENEC. Commissaire aux comptes suppléant : BAHON MICHEL.

4 rue Hélène Boucher Z.A.C. de Bellevue 35235 Thorigné-Fouillard
31/10/2008

OMEDIC, SOCIETE EN LIQUIDATION

448457895 - Société à responsabilité limitée
Capital : 7 500,00 EUR

Dissolution

Liquidateur amiable : FARDOUN Rahife.

45 square Général Paris Bollardière 35000 Rennes
31/10/2008

NICO, SOCIETE EN LIQUIDATION

482714417 - Société civile de construction-vente
Capital : 1 000,00 EUR

Dissolution

Associé indéfiniment responsable : SOSO. Associé indéfiniment responsable : CONANEC Antony. Liquidateur amiable : CONANEC Antony.

32 rue Jules Vallès 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
31/10/2008

O.C.D.M.

444166607 - Société à responsabilité limitée
Capital : 7 500,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant : LAGRILLE Didier.

rue Blaise Pascal Z.I. de Bellevue 35220 Châteaubourg
31/10/2008

HABITATION DE L'OUEST

484043245 - S.A.R.L. à associé unique
Capital : 2 000,00 EUR

Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Gérant associé unique : AOUINA Khadija.

1 bis rue d'Ouessant BP 96241 35760 Saint-Grégoire 35762
31/10/2008

SARL A.E.M.

485232516 - Société à responsabilité limitée
Capital : 30 000,00 EUR

Changement d'activité

Gérant : MAZUREAU Fabrice Georges Jean.

11 rue de la Santé 35000 Rennes
31/10/2008

SARL MONTAUBAN IMMOBILIER

490699451 - Société à responsabilité limitée
Capital : 8 000,00 EUR

Changement de gérant

Gérant : GAILLARD Gregory.

8 rue du Général de Gaulle 35360 Montauban-de-Bretagne
31/10/2008

A.B.D.I.,SOCIETE EN LIQUIDATION

493636989 - Société à responsabilité limitée
Capital : 8 000,00 EUR

Dissolution

Liquidateur amiable : IVANOVA Vania.

16 Belle Etoile 35490 Sens-de-Bretagne
Archives
SCI 11 RUE CONSTANTINE
SCI LIMOGE CORGNAC
TANIERA
COMITE AGRICOLE DU PAYS TOULOIS
ASSOCIATION SPORTIVE DE MEGEVE LES SPORTIFS MEGEVANS
CLOAREC ANNE