PACKPROSPECT : Boostez votre prospection BtoB


149 €

Economisez jusqu'a 80% sur vos fichiers de prospection BtoB qualifiés

Fichiers qualifiés avec nom des dirigeants - Sources officielles PACKPROSPECT.COM


Présentation générale

Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC et ses dirigeants.

Immatriculation

La société SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC est situé au 30190 BOURDIC
Elle a été crée le 29/10/2002 et elle est immatriculée sous le numéro 775864531 au greffe de NIMES
SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Forme juridique et activité

Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société coopérative agricole
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 1102B (Vinification) et le code de l'activité de son établissement principal est 1102B (Vinification).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.

Activité relative aux codes APE


Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :

  • la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
  • la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
  • la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
  • la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
  • la fabrication d'apéritifs à base de vins
  • le vieillissement des vins pour compte propre
  • les traitements œnologiques des vins

Mais sont exclues les activités :
  • la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
  • la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
  • l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
  • l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)

SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 12 888 000,00 pour un résultat net de 8 000,00 euros , grace à 1 établissements et 10 à 19 salariés.

Greffe

SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC est du ressort du greffe de NIMES dont les coordonnées postales sont 12 RUE CITE FOULC 30000 NIMES
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00.

TVA

Si SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35775864531.

Conventions collectives

Les conventions collectives applicables à SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC de part son activité de 1102B (Vinification) sont :

    Siége social et établissements

    SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC à son siége social situé au 30190 BOURDIC.
    Le numéro de téléphone est 0466812872
    Le numéro de fax est 04 66 81 23 20
    Les établissements sont les suivants :

    • soc coop agric les collines du bourdic cooperative sanilhac chemin de la cave 30700 sanilhac sagries france

    Evénements

    Les événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :

    • 24 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-08-31)
    • 08 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-08-31)
    • 01 août 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 19 août 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 08 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-08-31)
    • 22 juin 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 24 juin 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 11 juillet 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-08-31)
    • 20 juin 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 06 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-08-31)
    • 14 mai 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 21 mai 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-08-31)
    • 09 mai 2014 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 02 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-08-31)
    • 08 juin 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-08-31)
    • 24 novembre 2015 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 31 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-08-31)
    • 27 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-08-31)
    • 12 décembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-08-31)
    • 20 mai 2021 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 10 juin 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-08-31)
    • 08 juillet 2021 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 05 août 2021 : Modification (Modification de l'administration.)
    • 30 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-08-31)

    Dirigeants

    Les dirigeants :

    • 29/01/1966 : Bruno PANAFIEU (Administrateur)
    • 07/01/1979 : Camille MARCHAND (Administrateur)
    • 18/03/1970 : David BARON (Administrateur)
    • 20/05/1967 : Frederic ALTIER (Administrateur)
    • 15/02/1969 : Gérard BANCILLON (Administrateur)
    • 02/02/1961 : Henri MOURGUES (Administrateur)
    • 02/02/1958 : Hubert BEZZINA (Administrateur)
    • 12/06/1957 : Jacques DELBOS (Administrateur)
    • 18/03/1950 : Jean-paul VITIELLO (Administrateur)
    • 29/12/1965 : Jean-pierre MERIC (Administrateur)
    • 24/08/1968 : Laurent CADIERE (Administrateur)
    • 22/02/1962 : Lionel DUSSAUT (Administrateur)
    • 18/07/1974 : Loic SAUNIER (Administrateur)
    • 21/04/1973 : Stephane MERCIER (Administrateur)
    • 21/06/1982 : Vincent SERRANO (Administrateur)

    • L'âge moyen des 15 dirigeants de la société SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC est de 55 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 72 ans.

    Les modifications survenues dans l'administration de la société :

    • 01 août 2010 : ALTIER Frédéric Albert nom d'usage : ALTIER Frédéric devient administrateur. MARY Henri Louis nom d'usage : MARY Henri devient administrateur. BANCILLON Gérard Marc nom d'usage : BANCILLON Gérard devient administrateur. BARON David Michel nom d'usage : BARON David devient administrateur. BEZZINA Hubert Maurice Marie nom d'usage : BEZZINA Hubert devient administrateur. BOUDON Bernard nom d'usage : BOUDON Bernard devient administrateur. Exploitation agricole ARL BOURGUET FRERES devient administrateur. CADIERE Laurent Rolland nom d'usage : CADIERE Laurent devient administrateur. Sté civile d'exploitation agricole SCEA CAMARET devient administrateur. DELBOS Jacques nom d'usage : DELBOS Jacques devient administrateur. Exploitation agricole ARL EARL DE FONT DE CLARETTE devient administrateur. DUSSAUT Lionel Guy nom d'usage : DUSSAUT Lionel devient administrateur. GALANT Olivier nom d'usage : GALANT Olivier devient administrateur. Exploitation agricole ARL GANDIN devient administrateur. MERCIER Stéphane Gérard François nom d'usage : MERCIER Stéphane devient administrateur. MOURGUES Henri Robert Aimé nom d'usage : MOURGUES Henri devient administrateur. Exploitation agricole ARL EARL LES CHENES BLANCS devient administrateur. PANAFIEU Bruno Pierre nom d'usage : PANAFIEU Bruno devient administrateur. Exploitation agricole ARL EARL MAROUSSEL devient administrateur. PELLIER Christophe Louis Marcel nom d'usage : PELLIER Christophe devient administrateur. Exploitation agricole ARL EARL L'OLIVETTE devient administrateur. Gaec MAS DE LASPE devient administrateur. SAUNIER Loïc nom d'usage : SAUNIER Loïc devient administrateur. SERRANO Vincent André Henri nom d'usage : SERRANO Vincent devient administrateur. VITIELLO Jean-Paul nom d'usage : VITIELLO Jean-Paul devient administrateur.)
    • 19 août 2010 : ROUVEYROLLES Didier Yvon Paul Samuel nom d'usage : ROUVEYROLLES Didier n'est plus vice-président. ROBBY Jean Marie Gabriel nom d'usage : ROBBY Jean n'est plus trésorier. BANCILLON Gérard Marc nom d'usage : BANCILLON Gérard devient vice-président. BARON David Michel nom d'usage : BARON David devient trésorier.)
    • 22 juin 2011 : MARY Henri Louis nom d'usage : MARY n'est plus secrétaire. MARY Henri Louis nom d'usage : MARY n'est plus administrateur. BOUDON Bernard nom d'usage : BOUDON n'est plus administrateur. PELLIER Christophe Louis Marcel nom d'usage : PELLIER n'est plus administrateur.)
    • 24 juin 2011 : VITIELLO Jean-Paul nom d'usage : VITIELLO devient secrétaire.)
    • 20 juin 2012 : Exploitation agricole ARL GANDIN n'est plus administrateur. MARCHAND Camille Raymond Gabriel nom d'usage : MARCHAND devient administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de commissaire aux comptes titulaire FRANCE LANGUEDOC REVISION : ROUQUETTE Gerard nom d'usage : ROUQUETTE n'est plus représentant permanent.)
    • 14 mai 2013 : DURANDEUX Jean Paul nom d'usage : DURANDEUX n'est plus président. BANCILLON Gérard Marc nom d'usage : BANCILLON devient président. BARON David Michel nom d'usage : BARON devient vice-président. BANCILLON Gérard Marc nom d'usage : BANCILLON n'est plus vice-président. BARON David Michel nom d'usage : BARON n'est plus trésorier. NOUGIER David Marius nom d'usage : NOUGIER devient trésorier. Exploitation agricole ARL EARL DE FONT DE CLARETTE n'est plus administrateur. Gaec LES VIGNES ROUGES devient administrateur représenté(e) par MERIC Jean-Pierre nom d'usage : MERIC. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU GRAINS D'EULALIE devient administrateur représenté(e) par BANCILLON Gérard nom d'usage : BANCILLON.)
    • 09 mai 2014 : GALANT Olivier nom d'usage : GALANT n'est plus administrateur.)
    • 24 novembre 2015 : Gaec GAEC DU CLOS DE LA LIBROTTE devient administrateur. Exploitation agricole ARL L'ASPE devient administrateur.)
    • 20 mai 2021 : BEZZINA Hubert Maurice Marie nom d'usage : BEZZINA n'est plus administrateur. MOURGUES Henri Robert Aimé nom d'usage : MOURGUES n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur EARL MAROUSSEL Exploitation agricole ARL : PELADAN Philippe Daniel nom d'usage : PELADAN devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur EARL L'OLIVETTE Exploitation agricole ARL : PRADE Bruno Marie nom d'usage : PRADE devient représentant permanent. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU CLOS DE LA LIBROTTE devient administrateur représenté(e) par MOURGUES Henri Robert Aimé nom d'usage : MOURGUES. Gaec DU PETIT LASPE devient administrateur représenté(e) par ROBBY Olivier François nom d'usage : ROBBY)
    • 08 juillet 2021 : NOUGIER David Marius nom d'usage : NOUGIER n'est plus trésorier. Gaec LES VIGNES ROUGES devient trésorier représenté(e) par MERIC Jean-Pierre Marcel Aimé nom d'usage : MERIC)
    • 05 août 2021 : BANCILLON Gérard Marc nom d'usage : BANCILLON n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur EARL LES CHENES BLANCS Exploitation agricole ARL : nouvelle identité : NOUGIER David Marius nom d'usage : NOUGIER. Gaec MAS DE LASPE n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur L'ASPE Exploitation agricole ARL : ROBBY Philippe nom d'usage : ROBBY devient représentant permanent)

    Les mandats

    Les autres mandats des administrateurs :


      Frederic ALTIER

      Gérard BANCILLON

      Henri MOURGUES

      Hubert BEZZINA

      Jean-pierre MERIC

        Fiche synthétique

        Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC.

        IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT

        Nom ou raison sociale de l'entreprise SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC
        Identifiant de l'entreprise 775864531
        Numéro interne du siège 00014
        Adresse 30190 BOURDIC

        CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE

        Origine de la création de l'établissement Sans objet
        Année et mois de création de l'établissement lundi 01 janvier 1900
        Tranche d'effectif salarié de l'établissement 10 à 19 salariés
        Effectif salarié de l'établissement à la centaine près 10

        CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE

        Nature juridique de l'entreprise Société coopérative agricole
        Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire O
        Tranche d'effectif de l'entreprise 10 à 19 salariés
        Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près 10
        Catégorie d'entreprise Petite ou Moyenne Entreprise
        Année et mois de création de l'entreprise lundi 01 janvier 1900
        Tranche de chiffre d'affaires De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
        Dernier CA connu (2014) 12 888 000,00
        Résultat net 8 000,00

        ACTIVITE

        Indice de monoactivité de l'entreprise Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale
        Modalité de l'activité principale de l'entreprise Activité simple
        Caractère productif de l'entreprise Productif
        Activité principale du siège 1102B : Vinification
        Activité principale de l'entreprise 1102B : Vinification
        Activité principale 1102B : Vinification
        Première activité 1102B : Vinification
        Deuxième activité 8292Z : Activités de conditionnement

        Activité au siege

        Secteur agroalimentaire
        Catégorie Agroalimentaire
        Activite Vinification
        Synonyme fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
        Principal fabricant de vins
        Voir la fiche Sirene de SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC

        Evenements

        Cette section vous présente les différents événements de la société SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC.

        Depot des comptes 24 juillet 2008
        Cloture du 2007-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Depot des comptes 08 août 2009
        Cloture du 2008-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Modification 01 août 2010
        Modification de l'administration.
        ALTIER Frédéric Albert nom d'usage : ALTIER Frédéric devient administrateur. MARY Henri Louis nom d'usage : MARY Henri devient administrateur. BANCILLON Gérard Marc nom d'usage : BANCILLON Gérard devient administrateur. BARON David Michel nom d'usage : BARON David devient administrateur. BEZZINA Hubert Maurice Marie nom d'usage : BEZZINA Hubert devient administrateur. BOUDON Bernard nom d'usage : BOUDON Bernard devient administrateur. Exploitation agricole ARL BOURGUET FRERES devient administrateur. CADIERE Laurent Rolland nom d'usage : CADIERE Laurent devient administrateur. Sté civile d'exploitation agricole SCEA CAMARET devient administrateur. DELBOS Jacques nom d'usage : DELBOS Jacques devient administrateur. Exploitation agricole ARL EARL DE FONT DE CLARETTE devient administrateur. DUSSAUT Lionel Guy nom d'usage : DUSSAUT Lionel devient administrateur. GALANT Olivier nom d'usage : GALANT Olivier devient administrateur. Exploitation agricole ARL GANDIN devient administrateur. MERCIER Stéphane Gérard François nom d'usage : MERCIER Stéphane devient administrateur. MOURGUES Henri Robert Aimé nom d'usage : MOURGUES Henri devient administrateur. Exploitation agricole ARL EARL LES CHENES BLANCS devient administrateur. PANAFIEU Bruno Pierre nom d'usage : PANAFIEU Bruno devient administrateur. Exploitation agricole ARL EARL MAROUSSEL devient administrateur. PELLIER Christophe Louis Marcel nom d'usage : PELLIER Christophe devient administrateur. Exploitation agricole ARL EARL L'OLIVETTE devient administrateur. Gaec MAS DE LASPE devient administrateur. SAUNIER Loïc nom d'usage : SAUNIER Loïc devient administrateur. SERRANO Vincent André Henri nom d'usage : SERRANO Vincent devient administrateur. VITIELLO Jean-Paul nom d'usage : VITIELLO Jean-Paul devient administrateur.
        Modification 19 août 2010
        Modification de l'administration.
        ROUVEYROLLES Didier Yvon Paul Samuel nom d'usage : ROUVEYROLLES Didier n'est plus vice-président. ROBBY Jean Marie Gabriel nom d'usage : ROBBY Jean n'est plus trésorier. BANCILLON Gérard Marc nom d'usage : BANCILLON Gérard devient vice-président. BARON David Michel nom d'usage : BARON David devient trésorier.
        Depot des comptes 08 septembre 2010
        Cloture du 2009-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Modification 22 juin 2011
        Modification de l'administration.
        MARY Henri Louis nom d'usage : MARY n'est plus secrétaire. MARY Henri Louis nom d'usage : MARY n'est plus administrateur. BOUDON Bernard nom d'usage : BOUDON n'est plus administrateur. PELLIER Christophe Louis Marcel nom d'usage : PELLIER n'est plus administrateur.
        Modification 24 juin 2011
        Modification de l'administration.
        VITIELLO Jean-Paul nom d'usage : VITIELLO devient secrétaire.
        Depot des comptes 11 juillet 2011
        Cloture du 2010-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Modification 20 juin 2012
        Modification de l'administration.
        Exploitation agricole ARL GANDIN n'est plus administrateur. MARCHAND Camille Raymond Gabriel nom d'usage : MARCHAND devient administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de commissaire aux comptes titulaire FRANCE LANGUEDOC REVISION : ROUQUETTE Gerard nom d'usage : ROUQUETTE n'est plus représentant permanent.
        Depot des comptes 06 juillet 2012
        Cloture du 2011-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Modification 14 mai 2013
        Modification de l'administration.
        DURANDEUX Jean Paul nom d'usage : DURANDEUX n'est plus président. BANCILLON Gérard Marc nom d'usage : BANCILLON devient président. BARON David Michel nom d'usage : BARON devient vice-président. BANCILLON Gérard Marc nom d'usage : BANCILLON n'est plus vice-président. BARON David Michel nom d'usage : BARON n'est plus trésorier. NOUGIER David Marius nom d'usage : NOUGIER devient trésorier. Exploitation agricole ARL EARL DE FONT DE CLARETTE n'est plus administrateur. Gaec LES VIGNES ROUGES devient administrateur représenté(e) par MERIC Jean-Pierre nom d'usage : MERIC. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU GRAINS D'EULALIE devient administrateur représenté(e) par BANCILLON Gérard nom d'usage : BANCILLON.
        Depot des comptes 21 mai 2013
        Cloture du 2012-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Modification 09 mai 2014
        Modification de l'administration.
        GALANT Olivier nom d'usage : GALANT n'est plus administrateur.
        Depot des comptes 02 juin 2014
        Cloture du 2013-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Depot des comptes 08 juin 2015
        Cloture du 2014-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Modification 24 novembre 2015
        Modification de l'administration.
        Gaec GAEC DU CLOS DE LA LIBROTTE devient administrateur. Exploitation agricole ARL L'ASPE devient administrateur.
        Depot des comptes 31 octobre 2016
        Cloture du 2015-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Depot des comptes 27 juillet 2017
        Cloture du 2016-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Depot des comptes 12 décembre 2019
        Cloture du 2018-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Modification 20 mai 2021
        Modification de l'administration.
        BEZZINA Hubert Maurice Marie nom d'usage : BEZZINA n'est plus administrateur. MOURGUES Henri Robert Aimé nom d'usage : MOURGUES n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur EARL MAROUSSEL Exploitation agricole ARL : PELADAN Philippe Daniel nom d'usage : PELADAN devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur EARL L'OLIVETTE Exploitation agricole ARL : PRADE Bruno Marie nom d'usage : PRADE devient représentant permanent. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU CLOS DE LA LIBROTTE devient administrateur représenté(e) par MOURGUES Henri Robert Aimé nom d'usage : MOURGUES. Gaec DU PETIT LASPE devient administrateur représenté(e) par ROBBY Olivier François nom d'usage : ROBBY
        Depot des comptes 10 juin 2021
        Cloture du 2019-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Modification 08 juillet 2021
        Modification de l'administration.
        NOUGIER David Marius nom d'usage : NOUGIER n'est plus trésorier. Gaec LES VIGNES ROUGES devient trésorier représenté(e) par MERIC Jean-Pierre Marcel Aimé nom d'usage : MERIC
        Modification 05 août 2021
        Modification de l'administration.
        BANCILLON Gérard Marc nom d'usage : BANCILLON n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur EARL LES CHENES BLANCS Exploitation agricole ARL : nouvelle identité : NOUGIER David Marius nom d'usage : NOUGIER. Gaec MAS DE LASPE n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur L'ASPE Exploitation agricole ARL : ROBBY Philippe nom d'usage : ROBBY devient représentant permanent
        Depot des comptes 30 juin 2022
        Cloture du 2020-08-31
        Comptes annuels et rapports
        Voir les événements bodacc de SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC

        Dirigeants

        Cette section vous présente les dirigeants de la société SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC.

        Bruno PANAFIEU 56 ans
        Administrateur
        Camille MARCHAND 43 ans
        Administrateur
        David BARON 52 ans
        Administrateur
        Frederic ALTIER 55 ans
        Administrateur
        Gérard BANCILLON 53 ans
        Administrateur
        Henri MOURGUES 61 ans
        Administrateur
        Hubert BEZZINA 64 ans
        Administrateur
        Jacques DELBOS 65 ans
        Administrateur
        Jean-paul VITIELLO 72 ans
        Administrateur
        Jean-pierre MERIC 57 ans
        Administrateur
        Laurent CADIERE 54 ans
        Administrateur
        Lionel DUSSAUT 60 ans
        Administrateur
        Loic SAUNIER 48 ans
        Administrateur
        Stephane MERCIER 49 ans
        Administrateur
        Vincent SERRANO 40 ans
        Administrateur

        Etablissements

        Cette section vous présente les établissements actifs de SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC.

        BOURDIC

        10

        salarié(s)

        Siége social
        Enseigne
        SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC
        Nature
        Non renseigné
        Lieu
        Autre
        Surface
        Sans objet
        Durée
        Permanente
        Type
        Activité simple
        Production
        Productif

        SANILHAC SAGRIES

        NN

        salarié(s)

        Enseigne
        SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC
        Nature
        Non renseigné
        Lieu
        Non renseigné
        Surface
        Sans objet
        Durée
        Permanente
        Type
        Activité simple
        Production
        Productif

        BILAN

        Cette section vous présente le dernier bilan comptable public de SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC.

        Actif au bilan
        Année 2014
        Actif immobilisé 3 607 000
        Immobilisation incorporelle 12 000
        Immobilisation corporelle 3 401 000
        Immobilisation financière 194 000
        Actif circulant net 9 517 000
        Stock 2 643 000
        Avance 0
        Créance 4 268 000
        Placement 2 606 000
        Total Actif 13 124 000


        Passif au bilan
        Capitaux propre 6 700 000
        Autres fonds 0
        Provision 75 000
        Dette 6 349 000
        Total Passif 13 124 000


        Compte de résultat
        Chiffre d'affaire 12 888 000
        Produit d'exploitation 11 483 000
        Charge d'exploitation 11 353 000
        Résultat d'exploitation 130 000
        Produit financier net 19 000
        Charge financière 63 000
        Résultat financier -45 000
        Résultat courrant 86 000
        Produit exceptionnel 8 000
        Charges exceptionnelles 58 000
        Résultat exceptionnel -50 000
        Résultat net 8 000

        Concurrence

        Cette section vous présente les principaux concurrents de la société SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC.

        BICHOT SA 3 à 5 salariés
        14 RUE DU GENERAL DE GAULLE 21700 NUITS SAINT GEORGES
        BICHOT SA 3 à 5 salariés
        6 BD JACQUES COPEAU 21200 BEAUNE
        BICHOT SA 3 à 5 salariés
        4 RUE DE CUSSIGNY 21700 NUITS SAINT GEORGES
        BICHOT SA 3 à 5 salariés
        71640 MERCUREY
        THEODORE LEGRAS Unités non employeuses
        10 RUE DES PARTELAINES 51530 CHOUILLY
        THEODORE LEGRAS 0 salarié
        3 RUE DE L'ALLEE 51530 CHOUILLY
        UNION CAVES SALAVES COOPERATIV 0 salarié
        RTE DE ST THEODORIT 30610 SAUVE
        LES AMIS HOSPICCE CHATEAUNEUF 0 salarié
        MAIRIE 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
        VINI CHAMPAGNE 20 à 49 salariés
        21 RUE DU LUXEMBOURG 51420 CERNAY LES REIMS
        VINI CHAMPAGNE 20 à 49 salariés
        5 RUE SAINT NICOLAS 68150 OSTHEIM
        VINI CHAMPAGNE 20 à 49 salariés
        RUE ALOYS SENEFELDER 51100 REIMS
        LE VIGNERON SAVOYARD SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 3 à 5 salariés
        47 IMP DE LA CAVE 73310 RUFFIEUX
        VINESCENCE 10 à 19 salariés
        131 RTE HENRI FESSY 69220 SAINT JEAN D'ARDIERES
        VINESCENCE 10 à 19 salariés
        1 RUE DU BEAUJOLAIS 69460 ST ETIENNE DES OULLIERES
        CAVE COOPERATIVE BEAUJOLAISE DE QUINCIE 10 à 19 salariés
        LE RIBOUILLON 69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS
        CAVE DU CHATEAU DES LOGES 1 ou 2 salariés
        CHATEAU DES LOGES 69460 LE PERREON
        CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE 3 à 5 salariés
        CHATEAU BOIS DE LA SALLE 69840 JULIENAS
        CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE 3 à 5 salariés
        LE CLOS REYSSIER 71570 CHAINTRE
        CAVE COOP GRDS VINS DE FLEURIE 6 à 9 salariés
        69820 FLEURIE
        SOC.COOP.AGRI.CAVE DU CHATEAU DE CHENAS 6 à 9 salariés
        LES MICHAUDS 69840 CHENAS
        CAVE DES VINS FINS DE CRUET SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE. 3 à 5 salariés
        LD DIT GAVY 73800 CRUET
        CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON 3 à 5 salariés
        26770 SAINT PANTALEON LES VIGNES
        CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON 3 à 5 salariés
        20 RTE DE MONTELIMAR 26160 SAINT GERVAIS SUR ROUBION
        CAVE DES VIGNERONS DE ROCHEGUDE 6 à 9 salariés
        26790 ROCHEGUDE
        STE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE 6 à 9 salariés
        837 AV DES COTES DU RHONE 26790 SUZE LA ROUSSE
        COOP AGRICOLE DU NYONSAIS 10 à 19 salariés
        PL OLIVIER DE SERRES 26110 NYONS
        CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. 50 à 99 salariés
        22 RTE DE LARNAGE 26600 TAIN L'HERMITAGE
        CAVE COSTEBELLE 3 à 5 salariés
        AV DE PROVENCE 26790 TULETTE
        CAVE VIGNERONS REUNIS DE VALENCAY .... 1 ou 2 salariés
        CAVE DE FONTGUENAND 36600 FONTGUENAND
        SOC COOP AGRICOLE CELLIER DU BEAUJARDIN 6 à 9 salariés
        32 AV DU 11 NOVEMBRE 37150 BLERE
        SOC COOP AGRICOLE CELLIER DU BEAUJARDIN 6 à 9 salariés
        LD LA CHESNAYE 37270 ATHEE SUR CHER
        CAVE DES BONS SACHANTS 3 à 5 salariés
        191 AV PIERRE SEMARD 84120 PERTUIS
        CAVE DES BONS SACHANTS 3 à 5 salariés
        AV DE LA GARE 84120 PERTUIS
        LES VINS DROUETS FRERES 20 à 49 salariés
        4 RUE DE LA LOGE 44330 LA CHAPELLE HEULIN
        LES VINS DROUETS FRERES 20 à 49 salariés
        ZAC DE LA BOSSARDIERE 44430 LE LANDREAU
        VIGNERONS SUD ARDECHE 3 à 5 salariés
        RTE DE PRADONS 07120 RUOMS
        ETS THIENPONT DE BERLAERE ET FILS Unités non employeuses
        5 LE BOURG 33570 SAINT CIBARD
        S C AGRICOLE CHATEAU PIGOUDET 3 à 5 salariés
        RTE DE JOUQUES 83560 RIANS
        UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE 100 à 199 salariés
        RTE DE NYONS 26790 TULETTE
        UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE 100 à 199 salariés
        26130 SAINT RESTITUT
        UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE 100 à 199 salariés
        26790 BOUCHET
        UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE 100 à 199 salariés
        LES GARRIGUETTES 26790 TULETTE
        COOPER VINICOLE PRESSURAGE 0 salarié
        16 RTE NATIONALE 02400 AZY SUR MARNE
        COOPER VINICOLE PRESSURAGE VINIFICATION STOCKAGE 0 salarié
        32 RUE RUDENOISE 02310 CHARLY-SUR-MARNE
        SOC COOP UTIL MATERIEL AGRICOLE VINICOLE 0 salarié
        MAIRIE DE CHEZY SUR MARNE 02570 CHEZY SUR MARNE
        SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE CROUTTES STE COOP AGRICOLE 0 salarié
        5 RUE DE NANTEUIL 02310 CROUTTES SUR MARNE
        SOCIETE COOPERATIVE VITICOLE DE DOMPTIN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 0 salarié
        49 RUE DE LA FONTAINE 02310 DOMPTIN
        COOPERATIVE AGRICOLE VITICOLE DE GLAND 0 salarié
        62 RUE DE CHATEAU THIERRY 02400 GLAND
        COOPERATIVE VINICOLE DE ROMENY 0 salarié
        42 RTE NATIONALE 02310 ROMENY SUR MARNE
        COOPERATIVE VITICOLE DES RICEYS- BALNOT SUR LAIGNES 0 salarié
        RUE DE BISE 10340 LES RICEYS

        ENVIRONNEMENT LOCAL

        Cette section vous présente les principales société dont le siége social se trouve dans la même ville que de la société SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC.

        COMMUNE D AUBUSSARGUES 3 à 5 salariés
        30190 AUBUSSARGUES
        COMMUNE D AUBUSSARGUES 3 à 5 salariés
        30190 AUBUSSARGUES
        COMMUNE D AUBUSSARGUES 3 à 5 salariés
        HOTEL DE VILLE 30190 AUBUSSARGUES
        CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE 0 salarié
        MAIRIE 30190 AUBUSSARGUES
        CAFFAREL*BERTRAND ROBERT/ 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        CHABALIER*THIERRY/ 0 salarié
        LD BOUDOUSE 30190 AUBUSSARGUES
        CHABALIER*THIERRY/ 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        DUVERNOY*CHRISTIAN JEAN ROGER/ 0 salarié
        25 CHE DU ROC 30190 AUBUSSARGUES
        VAZ-NABAIS*LUIS/ 0 salarié
        6 CHE DE MONTESCAUD 30190 AUBUSSARGUES
        JOUFFRE*ROBERT/ 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        SCI DAAN 0 salarié
        CHE DE LA SOURCE 30190 AUBUSSARGUES
        SCI CHRELLE 0 salarié
        CHE DE LA SOURCE 30190 AUBUSSARGUES
        ANDRE*CHRISTIAN ROBERT ANGEL/ Unités non employeuses
        CHE DE L ANCIEN RESERVOIR 30190 AUBUSSARGUES
        EARL CLAVEL 1 ou 2 salariés
        30190 AUBUSSARGUES
        SCI LE ROC 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        FOUCHER*JEAN-PHILIPPE/ Unités non employeuses
        QUARTIER LE ROC 30190 AUBUSSARGUES
        ASSOCIATION MAL DE MER 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        SCI QUINTISSARGUES 0 salarié
        CHE DE COLLORGUES 30190 AUBUSSARGUES
        DAISY CHAIN ESPRIT NATURE 3 à 5 salariés
        QUARTIER LE RAJOL 30190 AUBUSSARGUES
        MAC LENON 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        VILLESECHE*MICHEL/ 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        CLAVEL*ERIC/ 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        CLAVEL*YVES/ 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        SARL L.E.C 1 ou 2 salariés
        RTE DE COLLORGUES 30190 AUBUSSARGUES
        CHABALIER*VIDAL/SABINE JACQUELINE/ 0 salarié
        QUA DE BOUDOUSE 30190 AUBUSSARGUES
        CLAVEL*CLAUDE/ 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        SAUNIER*LOIC/ 1 ou 2 salariés
        L'ARGILE 30190 AUBUSSARGUES
        SAUNIER*YOAN/ 1 ou 2 salariés
        ROUTE DE COLLORGUES 30190 AUBUSSARGUES
        SCI LE JARDIN D'EDEN 0 salarié
        6 CHE DE MONTESCAUD 30190 AUBUSSARGUES
        OZIL*NICOLAS/ 0 salarié
        CHE DE COLLORGUES 30190 AUBUSSARGUES
        GREGOIRE 0 salarié
        MAS CHAPELLE 30190 AUBUSSARGUES
        PELADAN*FREDERIC/ 0 salarié
        30190 AUBUSSARGUES
        SCI GIMY 0 salarié
        LE CAZARIL 30190 AUBUSSARGUES
        SCI MARMANELLE 0 salarié
        LE VILLAGE 30190 AUBUSSARGUES
        BAGGI*SAUMANT/LAURE ANDREE JEANINE/ 0 salarié
        QUARTIER LA CREMADE 30190 AUBUSSARGUES
        MAS CONIL 1 ou 2 salariés
        CHE DE COLLORGUES 30190 AUBUSSARGUES
        CHRISTIAN-ALEX 0 salarié
        8 CHE DE LA RIVIERE 30190 AUBUSSARGUES
        GILLAUX*ALEXANDRE/ 0 salarié
        CHE DE L ANCIEN RESERVOIR 30190 AUBUSSARGUES
        SOUJOL INSTALL PLOMBERIE ELECT CHAUFFA 0 salarié
        MAS DE CHAPELLE 30190 AUBUSSARGUES
        TYDGAT*MICHEL/ 1 ou 2 salariés
        22 RUE DU ROC 30190 AUBUSSARGUES
        MAYAUX 0 salarié
        RTE DE COLLORGUES 30190 AUBUSSARGUES
        SCI DU GRAND CHENE Unités non employeuses
        1 RUE DE LA MAITE 30190 AUBUSSARGUES
        NETERGIE 0 salarié
        15 RUE CAZARIL 30190 AUBUSSARGUES
        SC DU 15 RUE ANTOINE CARBOT 0 salarié
        LE ROC CAZARIL 30190 AUBUSSARGUES
        MARTINENT*OLIVIER/ 0 salarié
        CHE DE L ANCIEN RESERVOIR 30190 AUBUSSARGUES
        AUBUSS'ANE POUR TOUS 0 salarié
        RTE COLLORGUES 30190 AUBUSSARGUES
        MATHIEU*GALANT/CAROLINE/ 0 salarié
        LES BOUDOUSES 30190 AUBUSSARGUES
        EB PROJ 0 salarié
        LE MOULIN D'AUBUSSARGUES 30190 AUBUSSARGUES
        RODOT*MELANIE MADELEINE CHRISTIANE/ 0 salarié
        RTE DE COLLORGUES 30190 AUBUSSARGUES
        DURANDEUX TERRASSEMENT 1 ou 2 salariés
        CHEMIN DE COLLORGUES 30190 AUBUSSARGUES

        ICC PARTICIPATIONS
        GUILBAUT JOHNNY SERGE GEORGES
        SCI DE L OPTIQUE 14
        HYPERION OPTIQUE
        SCI LE BOIS DES LOGES
        SALFATI EDGARD